17 janv. 2007 ... The Royal Gazette is officially published on-line. Except for ... The Hydraulic
Shop (2007) Ltd. ... 1993. 08. 27. SUNNY BRAE LAUNDRY & DRY CLEANING
LTD. ...... 1994 Saturn SL2, ... 1-800-933-2222 (toll free within New Brunswick) ....
conformer au projet de règle les règles et les instructions com-.
The Royal Gazette
Gazette royale
Fredericton New Brunswick
Fredericton Nouveau-Brunswick ISSN 1714-9428
Vol. 165
Wednesday, January 17, 2007 / Le mercredi 17 janvier 2007
Notice to Readers
99
Avis aux lecteurs
The Royal Gazette is officially published on-line.
La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne.
Except for formatting, documents are published in The Royal Gazette as submitted.
Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dans la Gazette royale tels que soumis.
Material submitted for publication must be received by the Royal Gazette Coordinator no later than noon, at least 7 working days prior to Wednesday’s publication. However, when there is a public holiday, please contact the Royal Gazette Coordinator.
Les documents à publier doivent parvenir à la coordonnatrice de la Gazette royale, à midi, au moins 7 jours ouvrables avant le mercredi de publication. En cas de jour férié, veuillez communiquer avec la coordonnatrice de la Gazette royale.
Business Corporations Act
Loi sur les corporations commerciales
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of incorporation has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de constitution en corporation a été émis à :
Name / Raison sociale
Registered Office Bureau enregistré
Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
SEB D GROUP INC.
Dieppe
628331
2007
01
01
Cedar Hills Landscape & Design Ltd.
Saint John
629040
2006
12
31
629324 N.B. Ltd.
Saint John
629324
2006
12
21
629325 N.B. Ltd.
Grand Bay-Westfield
629325
2006
12
21
629326 N.B. Ltd.
Saint John
629326
2006
12
21
The Royal Gazette — January 17, 2007
100
Gazette royale — 17 janvier 2007
Fullerton Farms Ltd.
Long Reach
629327
2007
01
01
LOGAL INC.
Fredericton
629359
2006
12
22
Phoenix Electronic Commerce Systems (Canada) Inc.
Saint John
629361
2006
12
27
Keenan Construction Inc.
Bedell
629362
2006
12
27
CoveredBridge Potato Chip Company Inc.
Woodstock
629363
2006
12
27
THOR’S HOUSE OF THUNDER INC.
Moncton
629364
2006
12
27
Herbal Magic of Quispamsis Inc.
Quispamsis
629366
2006
12
27
629369 N.B. Inc.
Grand-Sault / Grand Falls
629369
2006
12
27
DAE Holdings Ltd.
Somerville
629370
2006
12
27
LINDENWOOD HOLDINGS INC.
Grand-Sault / Grand Falls
629376
2006
12
27
629380 N.B. Inc.
Moncton
629380
2006
12
27
Hazem Assi C.P. Inc.
Moncton
629381
2006
12
27
JCG P.C. Management Inc.
Saint John
629382
2006
12
27
John Gillis Professional Corporation Inc.
Saint John
629383
2006
12
27
RJG Legal Management Inc.
Saint John
629384
2006
12
27
R.J. Gillis, Q.C., PC Inc.
Saint John
629385
2006
12
27
629388 N.B. Ltd.
Moncton
629388
2006
12
28
AHT (FREDERICTON) INC.
Fredericton
629397
2006
12
28
MICRO INNOVATIONS INC.
Moncton
629400
2006
12
28
Walter D. Vail Professional Corporation
Fredericton
629410
2006
12
29
W.D. Vail P.C. Inc.
Fredericton
629411
2006
12
29
629413 N.B. Ltd.
Campbellton
629413
2006
12
29
629418 NEW BRUNSWICK INC.
Miramichi
629418
2006
12
29
The Hydraulic Shop (2007) Ltd.
Saint John
629425
2007
01
01
Doaktown Main St. Gas Bar Inc.
Doaktown
629429
2006
12
29
629430 N.B. Inc.
Moncton
629430
2006
12
29
629431 N.B. Inc.
Moncton
629431
2006
12
29
Jean Knowles Investments Inc.
Lower Newcastle
629433
2006
12
29
CSK Investments Inc.
Lower Newcastle
629439
2006
12
29
Garderie Happy Little Faces Daycare Inc
Beresford
629446
2006
12
29
Basque Property Management Inc.
Moncton
629450
2007
01
01
Drew Simpson Law Office Professional Corporation
Fredericton
629451
2007
01
02
DOKA CANADA LTD./LTEE
Saint John
629457
2007
01
02
Sunrise of Blainville G.P. Inc./ Sunrise de Blainville G.P. Inc.
Saint John
629462
2007
01
02
The Royal Gazette — January 17, 2007
101
Gazette royale — 17 janvier 2007
SZR Blainville Inc.
Saint John
629464
2007
01
02
Chris McCormack Ltd.
Miramichi
629466
2007
01
03
Fownes Manor Inc.
Hillsborough
629470
2007
01
03
Caribou Wind Park GP Limited
Memramcook
629471
2007
01
03
Rockerdale Ventures Limited
Saint John
629472
2007
01
03
Cridland Ventures Limited
Saint John
629473
2007
01
03
629474 N.B. Ltd.
Woodstock
629474
2007
01
03
Denborough Ventures Limited
Saint John
629475
2007
01
03
TRUE STYLE IMPORT INC.
Saint John
629481
2007
01
03
629484 N.B. Inc.
Rothesay
629484
2007
01
03
J. & M. McCarthy Consulting Ltd.
Grand Bay-Westfield
629487
2007
01
04
Inlet Enterprises Ltd.
Moncton
629488
2007
01
04
629491 NB INC.
Edmundston
629491
2007
01
04
_____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of continuance has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de prorogation a été émis à : Previous Jurisdiction Compétence antérieure
Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
Name / Raison sociale
Registered Office Bureau enregistré
Rockville Seiners Limited
Saint John
Nouvelle-Écosse / Nova Scotia
629182
2006
12
15
Rob Porter Holdings Limited
Saint John
Nouvelle-Écosse / Nova Scotia
629183
2006
12
15
ORBCOMM CANADA INC.
Saint John
Canada
629389
2006
12
31
SENTREX WIND SERVICES INC
Quispamsis
Canada
629408
2006
12
29
_____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of amendment has been issued to:
Name / Raison sociale
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de modification a été émis à :
Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
DOLLEMONT’S FUEL & BURNER SERVICE LTD.
005101
2007
01
02
DONNELLY’S ELECTRIC LIMITED
005133
2006
12
28
PINSLER HOLDINGS LTD.
013136
1993
08
27
SUNNY BRAE LAUNDRY & DRY CLEANING LTD.
015752
2007
01
02
S. KNOWLES LTD.
038488
2006
12
29
Jaden Enterprises Ltd.
043601
2006
12
28
The Royal Gazette — January 17, 2007
102
Gazette royale — 17 janvier 2007
I.F. INVESTMENT & PROPERTY LTD.
047961
2006
12
27
ROSS ISLAND SALMON LTD.
053054
2006
12
29
CALEDONIA WASTE-OIL ENTERPRISES LTD.
053677
2007
01
02
CAMCO CONSTRUCTION LTD.
056716
2006
12
28
G.R. BURNETT ENTERPRISES LTD.
500078
2006
12
29
J. KNOWLES HOLDINGS INC.
510797
2006
12
29
054279 N.B. LTD.
619304
2007
01
03
628655 N.B. Inc.
628655
2006
12
29
JCG P.C. Management Inc.
629382
2006
12
28
RJG Legal Management Inc.
629384
2006
12
28
_____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of amendment which includes a change in name has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de modification contenant un changement de raison sociale a été émis à :
Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
Name / Raison sociale
Previous name Ancienne raison sociale
V. N. KHANNA INVESTMENT INC.
V. N. KHANNA PROFESSIONAL CORPORATION
031932
2007
01
02
ENTREPRISES R.E.L. INC.
R.E. LEBLANC CONSULTANTS INC.
050669
2007
01
01
Girvan Auto Leasing Ltd.
Seaside Chevrolet Leasing Ltd.
616268
2007
01
04
Jonart Ventures Limited
Jutsum Ventures Limited
617547
2006
12
29
NORTHWOODS BROADCASTING LIMITED
Radio CJEM Limitée
620659
2007
01
02
BROOKS INDUSTRIES, INC.
C. S. BROOKS WORLD CARPETS, LTD.
621956
2007
01
04
Annan & Bird Lithographers, Inc.
Consolidated Annan & Bird Lithographers, Ltd.
628722
2007
01
03
Ossur Canada Inc.
608745 N.B. Inc.
629142
2007
01
01
SAMMY’S HOLDINGS LTD.
054307 N.B. LTÉE/LTD.
629377
2007
01
01
PLANIFICATION FINANCIÈRE PERSONNALISÉE INC.
628759 N.-B. INC.
629378
2007
01
01
FEDERAL CONSTRUCTION LTD.
628606 N.-B. INC.
629379
2007
01
01
M.C. Ventilation Ltd.
514072 N.B. Ltd.
629394
2007
01
01
Gray Rapids Lumber Company Limited
625980 NB LTD.
629441
2006
12
31
_____________________________________________________
The Royal Gazette — January 17, 2007
103
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of amalgamation has been issued to:
Gazette royale — 17 janvier 2007
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de fusion a été émis à : Reference
Amalgamated Corporation Corporation issue de la fusion
Amalgamating Corporations Corporations fusionnantes
Registered Office Bureau enregistré
Numéro de référence
Number Date Year Month Day année mois jour
Charles W. Read & Associates Ltd.
CHARLES W. READ & ASSOCIATES LTD. 513635 N.B. Ltd.
Fredericton
628952
2006
12
31
WOOD DISABILITY MANAGEMENT INC.
WOOD DISABILITY Bathurst MANAGEMENT INC. WOOD OCCUPATIONAL PLUS INC.
628995
2007
01
01
GESTION C.M. INC.
MÉGA GESTION LTÉE Gestion C.M. Inc. 507189 N.B. INC. 512577 NB Ltée LES ENTREPRISES AMI LIMITÉE
Caraquet
629101
2007
01
01
608745 N.B. Inc.
608745 N.B. Inc. Generation II Orthotics Inc.
Saint John
629142
2007
01
01
Birch Enterprises Ltd.
BIRCH ENTERPRISES LTD. BLUE HOLDINGS LTD.
Moncton
629276
2007
01
01
YVON A. LEBLANC FORESTRY LTD.
YVON A. LEBLANC FORESTRY LTD – LTEE 613031 N.B. INC.- 613031 N.-B. INC.
McKees Mills
629299
2006
12
31
LORNE BRETT MOTORS LTD.
LORNE BRETT MOTORS LTD. 629301 N.B. INC.
Saint John
629302
2006
12
31
ROBICHAUD MANAGEMENT LIMITÉE
J. V. ROBICHAUD ET FILS LIMITEE Shippagan - J. V. ROBICHAUD & SONS LIMITED ROBICHAUD MANAGEMENT LIMITEE
629305
2007
01
01
JCW HOLDINGS INC.
JCW HOLDINGS INC. 628966 N.B. Ltd.
Fredericton
629311
2007
01
01
Maritime Hydroseed (1988) Ltd.
MARITIME HYDROSEED (1988) LTD. 607077 N.B. Inc.
Saint John
629312
2007
01
01
627696 N.B. Ltd.
059418 N.B. LTD. 627696 N.B. Ltd.
Moncton
629316
2007
01
01
Gaudet Saulnier Assurance Ltée
GAUDET SAULNIER ASSURANCE LTÉE 624004 N.B. Inc.
Memramcook
629347
2007
01
01
K.C.R. Fisheries Ltd.
FUNDY SURF FISHERIES LTD. GEORGE JOHNSON & SONS FISHERIES LTD. C & R FISHERIES LTD. R.S. & T. FISHERIES LTD. LINTON BROS. FISHERIES LTD. K.C.R. FISHERIES LTD. 607008 N.B. LTD. Rockville Seiners Limited Rob Porter Holdings Limited
Saint John
629356
2007
01
01
Beckelm Farm Ltd.
BECKELM FARM LTD. 629129 N.B. Ltd.
Second North River
629371
2007
01
01
The Royal Gazette — January 17, 2007
104
Gazette royale — 17 janvier 2007
Eedda Capital Inc.
ADDEE DEVELOPMENTS LIMITED Rothesay EEDDA CAPITAL INC. 628049 N.B. Ltd.
629372
2007
01
01
LECLERC HOLDINGS INC.
LECLERC HOLDINGS INC. 513511 N.-B. INC.
Grand-Sault / Grand Falls
629373
2007
01
01
PAUL & ANDRÉ LTÉE
PAUL & ANDRÉ LTÉE 507211 N.-B. INC. MIC VON INC.
Grand-Sault / Grand Falls
629374
2007
01
01
DOOLY’S INC.
DOOLY’S WOODSTOCK INC. DOOLY’S GRAND-SAULT INC. DOOLY’S INC.
Moncton
629375
2006
12
30
054307 N.B. LTÉE/LTD.
Sammy’s Holdings Ltd. 054307 N.B. LTEE/LTD.
Bathurst
629377
2007
01
01
628759 N.-B. INC.
PLANIFICATION FINANCIERE PERSONNALISÉE INC. 628759 N.-B. INC.
Beresford
629378
2007
01
01
628606 N.-B. INC.
FEDERAL CONSTRUCTION LTD. 628606 N.-B. Inc.
Petit-Rocher Ouest / West
629379
2007
01
01
ORBCOMM CANADA INC.
ORBCOMM Canada Corp. ORBCOMM CANADA INC.
Saint John
629390
2006
12
31
040774 N.B. Ltd.
THIRTY-FIVE CHARLOTTE LTD. 040774 N.B. Ltd.
Rothesay
629391
2007
01
01
Coast Tire & Auto Service Ltd.
Versatile Powder Coating Inc. Coast Tire & Auto Service Ltd.
Saint John
629392
2007
01
01
514072 N.B. Ltd.
MC VENTILATION LTD. 514072 N.B. Ltd.
Saint John
629394
2007
01
01
PA. PE. JE. HOLDINGS LTD.
PA. PE. JE. HOLDINGS LTD. BURGESS TRAVEL LIMITED
Saint John
629395
2006
12
31
REOCO Limited
503402 N.B. INC. Saint John KINGSTON ROAD HOLDINGS N.B. INC. SEVEN CHALEUR INC. MERIVALE GENERAL CORPORATION REOCO MANNING GP CORP. REOCO Limited 506912 N.B. Inc.
629396
2007
01
01
ALLIANCE ASSURANCE HOLDING INC. Five Leaf Inc. ALLIANCE ASSURANCE HOLDING INC.
Grand-Sault / Grand Falls
629398
2007
01
02
Silver Falls Park Development Company Limited
H. C. MCNAMARA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED SILVER FALLS PARK DEVELOPMENT COMPANY LIMITED HALMAC HOLDINGS LTD.
Saint John
629406
2007
01
01
AB Miles Ltd.
AB MILES LTD. 050690 N.B. LTD.
Esteys Bridge
629424
2006
12
29
The Royal Gazette — January 17, 2007
105
Gazette royale — 17 janvier 2007
SITTHE CANADA LTD.
CARDINAL INVESTORS, INC. SITHE ENERGIES CANADA POWER SERVICES INC. Sithe Southdown, Ltd. SITHE CANADIAN PIPELINES LTD. SITHE SOUTHDOWN PIPELINES LTD. 609371 N.B. Ltd. SITHE CANADA LTD. 616891 N.B. INC.
Saint John
629434
2007
01
01
SITHE CANADIAN HOLDINGS INC.
SITHE CANADIAN HOLDINGS INC. Saint John SITTHE CANADA LTD.
629435
2007
01
01
HAZELHURST HOLDINGS LTD.
Hazelhurst Holdings Ltd. 617193 N.B. INC.
Saint John
629436
2007
01
01
SITHE CANADIAN HOLDINGS INC.
SITHE CANADIAN HOLDINGS INC. Saint John HAZELHURST HOLDINGS LTD.
629437
2007
01
01
625980 NB LTD.
GRAY RAPIDS LUMBER COMPANY LIMITED 625980 NB LTD.
629441
2006
12
31
Jacksonville
_____________________________________________________
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of dissolution has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de dissolution a été émis à : Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
Name / Raison sociale
Registered Office Bureau enregistré
IRP GATEWAY INC.
Saint John
506884
2006
12
29
Sithe Energies Canadian Development, Ltd.
Saint John
508409
2006
12
22
36 Adelaide General Corporation
Saint John
509612
2006
12
29
TECH PARK GENERAL CORPORATION
Saint John
510451
2006
12
29
MANNING INDUSTRIAL PROPERTIES CORPORATION
Saint John
512509
2006
12
29
MANNING SHOPPING CENTRE CORPORATION
Saint John
512510
2006
12
29
IRP MANNING (NB) CORP.
Saint John
512572
2006
12
29
THE GREAT PLANT COMPANY INC./ LA COMPAGNIE GREAT PLANT INC.
Saint John
516100
2006
12
29
_____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of discontinuance has been issued to:
Name / Raison sociale
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de cessation a été émis à :
Jurisdiction of Continuance Compétence de prorogation
Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
TRI-HOLDINGS LTD.
Colombie-Britannique / British Colombia
016371
2006
12
22
DH CANADA INC.
Nouvelle-Écosse / Nova Scotia
506281
2006
12
19
_____________________________________________________
The Royal Gazette — January 17, 2007
106
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of revival has been issued to:
Gazette royale — 17 janvier 2007 SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de reconstitution a été émis à : Date Year Month Day année mois jour
Reference Number Numéro de référence
Name / Raison sociale
KILLAM DRIVE SURPLUS CENTRE LTD.
037326
2006
12
08
_____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of registration of extra-provincial corporation has been issued to:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat d’enregistrement de corporation extraprovinciale a été émis à : Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
Name / Raison sociale
Jurisdiction Compétence
Agent and Address Représentant et adresse
WESTON FOODS (CANADA) INC.
Ontario
Walter D. Vail Fredericton
629149
2006
12
14
OLYMPIC MOTORS CORPORATION
Canada
Peter Wright Moncton
629259
2006
12
19
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS CANADA INC. PRODUITS D’INGÉNIERIE GOODYEAR CANADA INC.
Canada
Donald MacGowan Saint John
629281
2006
12
20
Latin American Minerals Inc.
Canada
SMSS Corporate Services (NB) Inc. Saint John
629350
2006
12
22
Creststreet 2007 General Partner Limited/ Ontario Commandite Creststreet 2007 Limitee
SMSS Corporate Services (NB) Inc. Saint John
629403
2006
12
29
VALLEY TRUSS & METAL LTD.
Susan K. Layton Saint John
629404
2006
12
29
Ontario
_____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of amendment of registration of extraprovincial corporation has been issued to:
Name / Raison sociale
4304853 CANADA INC.
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de modification de l’enregistrement de corporation extraprovinciale a été émis à :
Previous name Ancienne raison sociale
Reference Number Numéro de référence
COMPAGNIE DE CONSTRUCTION 619981 DE PIPELINES BANISTER INC. BANISTER PIPELINE CONSTRUCTION INC. _____________________________________________________
Date Year Month Day année mois jour
2006
12
20
The Royal Gazette — January 17, 2007
107
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of registration of amalgamated corporation has been issued to the following extra-provincial corporations:
Amalgamated Corporation Corporation issue de la fusion
Amalgamating Corporations Corporations fusionnantes
BIOGENIE S.R.D.C. INC.
Biogenie S.R.D.C. Inc.
Gazette royale — 17 janvier 2007 SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat d’enregistrement d’une corporation extraprovinciale issue de la fusion a été émis aux corporations extraprovinciales suivantes : Agent and Address Représentant et adresse
John D. Larlee Fredericton
Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
629438
2006
12
28
Partnerships and Business Names Registration Act
Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of business name has been registered:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat d’appellation commerciale a été enregistré :
Registrant of Certificate Enregistreur du certificat
Address of Business or Agent Adresse du commerce ou du représentant
Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
T. ENGLISH ENTERPRISES
Ted English
Moncton
629146
2006
12
14
Airtech Consulting Services
Lisa Hutchings
Moncton
629147
2006
12
14
Assurance Beausejour Gaudet INSURANCE
ASSURANCE BEAUSEJOUR
Dieppe
629178
2006
12
15
FEDERAL PROTECTIVE SERVICES (FPS)
Robert W. Sabine
Saint John
629180
2006
12
15
Salon Top Chic
Mélanie B. Thibodeau
Edmundston
629206
2006
12
18
Country Quilt Finishing
Wendy Billing
Greater Lakeburn
629214
2006
12
18
D & S Smith Salvage and Sales
Danny Smith
Woodstock
629216
2006
12
18
Clinical Massage Group
Peter Simpson
Moncton
629260
2006
12
18
Countertop Creations
COUNTERTOPS PLUS LTD.
Moncton
629261
2006
12
19
Marsh’s Private Client Service
MARSH CANADA LIMITED/ MARSH CANADA LIMITÉE
Saint John
629329
2007
01
01
Services aux particuliers de Marsh
MARSH CANADA LIMITED/ MARSH CANADA LIMITÉE
Saint John
629330
2007
01
01
Location Crédit Ford Canada
CANADIAN ROAD LEASING COMPANY/COMPAGNIE DE LOCATION CANADIAN ROAD
Saint John
629337
2007
01
01
Location Crédit Jaguar Canada
CANADIAN ROAD LEASING COMPANY/COMPAGNIE DE LOCATION CANADIAN ROAD
Saint John
629338
2007
01
01
Location Services financiers Land Rover
CANADIAN ROAD LEASING COMPANY/COMPAGNIE DE LOCATION CANADIAN ROAD
Saint John
629339
2007
01
01
Name / Raison sociale
The Royal Gazette — January 17, 2007
108
Gazette royale — 17 janvier 2007
Location Crédit Mazda Canada
CANADIAN ROAD LEASING COMPANY/COMPAGNIE DE LOCATION CANADIAN ROAD
Saint John
629340
2007
01
01
Location Services financiers Auto. Volvo
CANADIAN ROAD LEASING COMPANY/COMPAGNIE DE LOCATION CANADIAN ROAD
Saint John
629341
2007
01
01
Location Services financiers Automobiles Volvo du Canada
CANADIAN ROAD LEASING COMPANY/COMPAGNIE DE LOCATION CANADIAN ROAD
Saint John
629342
2007
01
01
Restorative Muscle Care
Sherry Robichaud
Riverview
629348
2006
12
22
Bijouterie Celebrite Jewellers (2007) SLC
Stephanie Chamberlain
Bathurst
629354
2007
01
01
Olynyks Carpentry
David Igor Olynyk
Riverview
629360
2006
12
27
FNC & Associates
Vincent Larry
Eel Ground
629365
2006
12
27
Easy Lawn Hydroseeding
John Fraser
Rothesay
629367
2006
12
27
Blaney Cycle Supply
Barry Blaney
Nortondale
629387
2006
12
28
Versatile Powder Coating
Coast Tire & Auto Service Ltd.
Saint John
629393
2007
01
01
CANOAK-SPORT.COM
Guy Gino Roy
Shippagan
629401
2006
12
28
GAMES R US
Aaron Jeremy Gates
Saint John
629405
2006
12
29
R.E. LEBLANC CONSULTANTS
628056 NB INC.
Moncton
629407
2006
12
27
Desperado Chop Shop
Matt Sturgeon
New Maryland
629440
2006
12
29
Gauvis Scrap Metal Removal
Serge Gauvin
Cocagne
629447
2006
12
29
Hoffmann Design
John Hoffmann
Mazerolle Settlement
629449
2007
01
01
DNR Jewellery Exchange
David Rule
Riverview
629463
2007
01
02
Haddad Marketing
Thomas David Haddad
Moncton
629465
2007
01
02
WWWA Wholesale
Warren Whittle
Moncton
629467
2007
01
03
Bathurst Mortgage Center/ Centre Hypothécaire Bathurst
Amédée Haché
Bathurst
629468
2007
01
03
Pisces Restaurant
Gaston Frigault
Moncton
629469
2007
01
03
Stewart Heavy Equipment Contracting & Rentals
Christopher W. Stewart
Miramichi
629485
2007
01
03
Melvin’s Cafeteria
Debra Melvin
Saint John
629490
2007
01
04
_____________________________________________________
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of renewal of business name has been registered:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de renouvellement d’appellation commerciale a été enregistré :
Name / Raison sociale
Registrant of Certificate Enregistreur du certificat
Address of Business or Agent Adresse du commerce ou du représentant
Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
CLIFF’S DRIVER TRAINING
Clifford C. Hodgin
Sussex
339700
2006
12
30
Bowlarama @ 2020
Lockmac Holdings Limited
Bathurst
352235
2007
01
02
The Royal Gazette — January 17, 2007
109
Gazette royale — 17 janvier 2007
La Zone
Lockman Holdings Limited
Bathurst
352236
2007
01
02
RIVER HAVEN CAMPGROUND
Richard Stephen Matheson
Tabusintac
352797
2007
01
02
Trevors Hyundai
RAE’S TRAILER & SPORTS CENTER LTD.
Miramichi
352981
2006
12
27
Dia Care Diabetes Education And Consultation Services
Shelley L. Jones
Salisbury
353037
2006
12
27
Concept Communications
INVESTO INC.
Dieppe
353065
2006
12
31
CustomerWorks
CustomerWorks Limited Partnership
Fredericton
353145
2006
12
14
PENTARUS GRAPHICS
Jeffrey D. McPhee
Moncton
353200
2007
01
03
_____________________________________________________
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of cessation of business or use of business name has been registered:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de cessation de l’activité ou de cessation d’emploi de l’appellation commerciale a été enregistré : Address / Adresse
Name / Raison sociale
Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
MARSH PRIVATE CLIENT SERVICES/ SERVICE D’ASSURANCE PRIVILÉGIÉ MARSH
Saint John
347095
2007
01
01
By The Web Services
Riverview
351447
2007
01
03
FULLERTON FARMS
Long Reach
608839
2006
12
31
Cedar Hills Landscape & Design
Saint John
623904
2006
12
31
_____________________________________________________
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of partnership has been registered:
Name / Raison sociale
Partners / Membres
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de société en nom collectif a été enregistré : Address of Business or Agent Adresse du commerce ou du représentant
Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
GE CANADA VEHICLE & EQUIPMENT SERVICES/ GE CANADA SERVICES DE LOCATION DE VÉHICULES ET D’ÉQUIPEMENT
General Electric Capital Canada/ Capital Generale Electrique du Canada GE Canada Vel Services Company
Saint John
629209
2006
12
18
SHELL CANADA ENERGY
SHELL CANADA LIMITED SHELL CANADA LIMITEE BlackRock Ventures Inc. 6581528 Canada Ltd.
Fredericton
629285
2007
01
01
_____________________________________________________
The Royal Gazette — January 17, 2007
110
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of dissolution of partnership has been registered:
Gazette royale — 17 janvier 2007
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de dissolution de société en nom collectif a été enregistré : Address / Adresse
Name / Raison sociale
D & S Smith Salvage and Sales
Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
628862
2006
Woodstock
12
18
_____________________________________________________
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of change of membership of partnership has been registered:
Name / Raison sociale
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de changement d’associé d’une société en nom collectif a été enregistré :
Retiring Partners Associés sortants
Incoming Partners Nouveaux associés
Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
LE Groupe Zarico
Serge Leblanc
353345
2006
12
11
Imex Universal Trading
Osoma Al Masri
621907
2006
12
04
Point Click Media Productions
Marc Godin
625839
2006
12
04
Limited Partnership Act
Loi sur les sociétés en commandite
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partnership Act, a declaration of extra-provincial limited partnership has been filed:
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une déclaration de société en commandite extraprovinciale a été déposée par :
Name / Raison sociale
Principal place in New Brunswick Principal établissement au Nouveau-Brunswick
ITT Canada Trading L.P.
Saint John
Ontario
SMSS Corporate Services (NB) Inc. Saint John
629177
2006
12
15
ENERVEST FTS LIMITED PARTNERSHIP 2006 II
Saint John
Alberta
SMSS Corporate Services (NB) Inc. Saint John
629280
2006
12
20
NCE DIVERSIFIED FLOWTHROUGH (07) LIMITED PARTNERSHIP
Saint John
Ontario
SMSS Corporate Services (NB) Inc. Saint John
629306
2006
12
21
Norrep Performance 2007 Flow-Through (07) Limited Partnership
Saint John
Ontario
SMSS Corporate Services (NB) Inc. Saint John
629453
2006
12
29
Jurisdiction Compétence
Agent and Address Représentant et adresse
Reference Number Numéro de référence
Date Year Month Day année mois jour
The Royal Gazette — January 17, 2007 Creststreet 2007 Limited
111 Saint John
Ontario
Gazette royale — 17 janvier 2007 SMSS Corporate Services (NB) Inc. Saint John
629454
2006
12
29
_____________________________________________________
PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partnership Act, a declaration of withdrawal of extra-provincial limited partnership has been filed:
Name / Raison sociale
Jurisdiction Compétence
Precision Limited Partnership
Alberta
SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une déclaration de retrait de société en commandite extraprovinciale a été déposée par : Agent and Address Représentant et adresse
SMMS Corporate Services (NB) Inc. Saint John
Reference Number Numéro de référence
400608
Date Year Month Day année mois jour
2006
12
14
Department of Public Safety
Ministère de la Sécurité publique
SALE OF MOTOR VEHICLES Take notice that the Registrar of Motor Vehicles, Province of New Brunswick will be disposing of the following vehicles on or after January 17, 2007: 1994 Oldsmobile Cierra, Serial No. 1G3NL53MXRM019329 License Plate: GNE089 Registered Owner: Phillipe Gigou Vehicle located at George’s Towing, Shediac
VENTE DE VÉHICULES À MOTEUR Sachez que le registraire des véhicules à moteur de la province du Nouveau-Brunswick mettra en vente les véhicules à moteur suivants le 17 janvier 2007 : Oldsmobile Cierra 1994, numéro de série : 1G3NL53MXRM019329 Numéro d’immatriculation : GNE089 Propriétaire immatriculée : Phillipe Gigou Véhicule se trouvant actuellement chez George’s Towing, Shediac Mercury Topaz 1994, numéro de série : 1MEBM36X9RK614323 Numéro d’immatriculation : BQN367 Propriétaire immatriculée : Daniel Gautreau Véhicule se trouvant actuellement chez George’s Towing, Shediac Nissan Sentra 1994, numéro de série : 3N1EB32S0RL003290 Numéro d’immatriculation : GPH612 Propriétaire immatriculée : Khalid El Idrissi Véhicule se trouvant actuellement chez George’s Towing, Shediac Pontiac Sunbird 1991, numéro de série : 1G2JB51K8M7625078 Numéro d’immatriculation : 828RYW Propriétaire immatriculée : Huguette Hebert Véhicule se trouvant actuellement chez George’s Towing, Shediac Pontiac 6000 1990, numéro de série : 1G2AF51T3L6237306 Numéro d’immatriculation : GLF924 Propriétaire immatriculée : Lorraine Mallet Véhicule se trouvant actuellement chez George’s Towing, Shediac
1994 Mercury Topaz, Serial No. 1MEBM36X9RK614323 License Plate: BQN367 Registered Owner: Daniel Gautreau Vehicle located at George’s Towing, Shediac 1994 Nissan Sentra, Serial No. 3N1EB32S0RL003290 License Plate: GPH612 Registered Owner: Khalid El Idrissi Vehicle located at George’s Towing, Shediac 1991 Pontiac Sunbird, Serial No. 1G2JB51K8M7625078 License Plate: 828RYW Registered Owner: Huguette Hebert Vehicle located at George’s Towing, Shediac 1990 Pontiac 6000, Serial No. 1G2AF51T3L6237306 License Plate: GLF924 Registered Owner: Lorraine Mallet Vehicle located at George’s Towing, Shediac
The Royal Gazette — January 17, 2007
112
Gazette royale — 17 janvier 2007
1992 Chevrolet Cavalier, Serial No. 3G1JC1149NS819505 License Plate: BKU270 Registered Owner: Donald Nowlan Vehicle located at George’s Towing, Shediac
Chevrolet Cavalier 1992, numéro de série : 3G1JC1149NS819505 Numéro d’immatriculation : BKU270 Propriétaire immatriculée : Donald Nowlan Véhicule se trouvant actuellement chez George’s Towing, Shediac
1997 Chrysler Intrepid, Serial No. 2C3HH46T3VH677667 License Plate: BUC892 Registered Owner: Thomas Atwin Vehicle located at Kitchen’s Auto Body Repair
Chrysler Intrepid 1997, numéro de série : 2C3HH46T3VH677667 Numéro d’immatriculation : BUC892 Propriétaire immatriculée : Thomas Atwin Véhicule se trouvant actuellement chez Kitchen’s Body Repair Cadillac DeVille 1988, numéro de série : 1G6CD1159J4239206 Numéro d’immatriculation : GMH061 Propriétaire immatriculée : Eric Fraser Véhicule se trouvant actuellement chez Kitchen’s Body Repair Mercury Topaz 1994, numéro de série : 1MEBM31X4RK609229 Numéro d’immatriculation : GBW281 Propriétaire immatriculée : Raymond Ryan Véhicule se trouvant actuellement chez Kitchen’s Body Repair Mazda Protégé 1999, numéro de série : JM1BJ2220X0152094 Numéro d’immatriculation : AMSJ356 Propriétaire immatriculée : Sean Foley Véhicule se trouvant actuellement chez Kitchen’s Body Repair Plymouth Acclaim 1993, numéro de série : 3P3XA46K7PT622927 Numéro d’immatriculation : BQG416 Propriétaire immatriculée : Merton A. Jewett Véhicule se trouvant actuellement chez Kitchen’s Body Repair Pontiac Grand Am 1995, numéro de série : 1G2NE53M0SM607700 Numéro d’immatriculation : BSO621 Propriétaire immatriculée : Loretta Sabattis Véhicule se trouvant actuellement chez Kitchen’s Body Repair
1988 Cadillac DeVille, Serial No. 1G6CD1159J4239206 License Plate: GMH061 Registered Owner: Eric Fraser Vehicle located at Kitchen’s Auto Body Repair 1994 Mercury Topaz, Serial No. 1MEBM31X4RK609229 License Plate: GBW281 Registered Owner: Raymond Ryan Vehicle located at Kitchen’s Auto Body Repair 1999 Mazda Protégé, Serial No. JM1BJ2220X0152094 License Plate: AMSJ356 Registered Owner: Sean Foley Vehicle located at Kitchen’s Auto Body Repair 1993 Plymouth Acclaim, Serial No. 3P3XA46K7PT622927 License Plate: BQG416 Registered Owner: Merton A. Jewett Vehicle located at Kitchen’s Auto Body Repair 1995 Pontiac Grand Am, Serial No. 1G2NE53M0SM607700 License Plate: BSO621 Registered Owner: Loretta Sabattis Vehicle located at Kitchen’s Auto Body Repair 1989 Honda Civic, Serial No. 2HGEJ6513XH916623 License Plate: BZJ315 Registered Owner: Nicole Leger Vehicle located at Loftus Auto, Moncton 1989 Mercury Grand, Serial No. 2MEBM74F9KX692914 License Plate: BBU310 Registered Owner: Mack Bear Vehicle located at Loftus Auto, Moncton
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Auto
Honda Civic 1989, numéro de série : 2HGEJ6513XH916623 Numéro d’immatriculation : BZJ315 Propriétaire immatriculée : Nicole Leger Véhicule se trouvant actuellement chez Loftus Auto, Moncton Mercury Grand 1989, numéro de série : 2MEBM74F9KX692914 Numéro d’immatriculation : BBU310 Propriétaire immatriculée : Mack Bear Véhicule se trouvant actuellement chez Loftus Auto, Moncton
The Royal Gazette — January 17, 2007
1994 Saturn SL2, Serial No. 1G8ZJ5576RZ240499 License Plate: GPD559 Registered Owner: Monique Thebeau Vehicle located at Loftus Auto, Moncton
113
Gazette royale — 17 janvier 2007
Saturn SL2 1994, numéro de série : 1G8ZJ5576RZ240499 Numéro d’immatriculation : GPD559 Propriétaire immatriculée : Monique Thebeau Véhicule se trouvant actuellement chez Loftus Auto, Moncton
Service New Brunswick
Services Nouveau-Brunswick
Public notice of change of registered name under the Change of Name Act, chapter C-2.001, s.9(1.1) of the acts of New Brunswick, 1987
Avis public de changement de noms enregistrés en application de la Loi sur le changement de nom, lois du Nouveau-Brunswick de 1987, c.C-2.001, art.9(1.1)
Previous Registered Name: Robert William Palmer Delancey Abdullah Robert Delancey New Registered Name: 22 Seventh Street Address: Moncton, N.B. E1E 3G1 November 28, 2006 Date Granted:
Ancien nom enregistré :
Previous Registered Name: Bernhard Alexander Dütz New Registered Name: Lone Wolf Address: 540 Route 103 Woodstock, N.B. E7M 6B6 December 13, 2006 Date Granted:
Ancien nom enregistré : Nouveau nom enregistré : Adresse :
Previous Registered Name: Christopher Richard Francis Kolacz New Registered Name: Christopher Richard Francis Kolaczan 161 Main Street, Apt. #1 Address: Fredericton, N.B. E3A 1C6 December 15, 2006 Date Granted:
Ancien nom enregistré :
Previous Registered Name: Marie Apauline Durelle New Registered Name: Pauline Marie Apolline Durelle Address: 35 W. Gay Néguac, N.B. E9G 1Z2 January 2, 2007 Date Granted:
Ancien nom enregistré : Nouveau nom enregistré : Adresse :
Previous Registered Name: Joseph Denis Bélanger Gaétan Bélanger New Registered Name: 78, rue Beaurivage N. Address: Ste-Florence, Québec G0J 2M0 January 3, 2007 Date Granted:
Ancien nom enregistré : Nouveau nom enregistré : Adresse :
Josée Dubé Acting Registrar General of Vital Statistics
Robert William Palmer Delancey Nouveau nom enregistré : Abdullah Robert Delancey Adresse : 22, rue Seventh Moncton (N.-B.) E1E 3G1 Date d’accueil de la demande : Le 26 novembre 2006 Bernhard Alexander Dütz Lone Wolf 540, route 103 Woodstock (N.-B.) E7M 6B6 Date d’accueil de la demande : Le 13 décembre 2006 Christopher Richard Francis Kolacz Nouveau nom enregistré : Christopher Richard Francis Kolaczan 161, rue Main, app. #1 Adresse : Fredericton (N.-B.) E3A 1C6 Date d’accueil de la demande : Le 15 décembre 2006 Marie Apauline Durelle Pauline Marie Apolline Durelle 35 W. Gay Néguac (N.-B.) E9G 1Z2 Date d’accueil de la demande : Le 2 janvier 2007 Joseph Denis Bélanger Gaétan Bélanger 78, rue Beaurivage N. Ste-Florence (Québec) G0J 2M0 Date d’accueil de la demande : Le 3 janvier 2007 Josée Dubé Registraire générale des statistiques de l’état civil par intérim
The Royal Gazette — January 17, 2007
114
Gazette royale — 17 janvier 2007
New Brunswick Securities Commission
Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick
NOTICE OF AMENDMENT TO BY-LAW NO. 1 Pursuant to subsection 22(4) of the Securities Act. 1) Title By-Law No. 1 – General Business Affairs – amendment to Article 3.1
AVIS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 1 Sous le régime du paragraphe 22(4) de la Loi sur les valeurs mobilières 1) Titre Modification du paragraphe 3.1 du Règlement administratif no 1 sur la conduite générale des affaires
2) Substance of amendment The Commission has amended Article 3.1 to make provision for an annual retainer of $2,000 for the Lead Member and chairs of committees.
2) Teneur de la modification La Commission a modifié le paragraphe 3.1 du règlement administratif afin qu’une provision annuelle de 2 000 $ puisse être versée au membre principal et aux présidents de comité.
3) Date of coming into force: 1 January 2007
3) Date d’entrée en vigueur Le 1er janvier 2007
4) To obtain a copy of the by-law: By-Law No. 1 is available on the Commission website at www.nbsc-cvmb.ca
4) Comment obtenir un exemplaire du règlement Le règlement administratif no 1 se trouve dans le site Web de la Commission : www.nbsc-cvmb.ca
A paper copy may be obtained:
Il est possible de s’en procurer un exemplaire sur papier
in writing: Secretary New Brunswick Securities Commission 300-85 Charlotte Street Saint John, New Brunswick E2L 2J2
par écrit : Secrétaire Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick 85, rue Charlotte, bureau 300 Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2
by telephone: 1-800-933-2222 (toll free within New Brunswick) 506-658-3060 (outside New Brunswick) 506-658-3059 (fax your request)
par téléphone : 1-800-933-2222 (sans frais au Nouveau-Brunswick) 506-658-3060 (de l’extérieur du Nouveau-Brunswick) 506-658-3059 (télécopieur)
by email:
[email protected]
par courriel :
[email protected]
________________
________________
REQUEST FOR COMMENT Notice and Request for Comment – Publishing for comment proposed National Instrument 41-101 – General Prospectus Requirements (the proposed NI 41-101 rule), resulting in consequential amendments to National Instrument 14-101 – Definitions, National Instrument 44-101 – Short Form Prospectus Distributions, National Instrument 44-102 – Shelf Distributions, National Instrument 44-103 – Post-Receipt Pricing, National Instrument 45-101 – Rights Offerings, National Instrument 51-102 – Continuous Disclosure Obligations, National Instrument 81-101 – Mutual Fund Prospectus Disclosure, National Instrument 81-104 – Commodity Pools, and National Policy 43-201 – Mutual Reliance Review System for Prospectuses,
DEMANDE DE COMMENTAIRES Avis de consultation et demande de commentaires – Publication en vue de recueillir des commentaires au sujet du projet de règle relative à la Norme canadienne 41-101 – Obligations générales relatives au prospectus (projet de règle NC 41-101), qui mena à des modifications corrélatives à la Norme canadienne 14-101 – Définitions, la Norme canadienne 44-101 – Placement de titres au moyen d’un prospectus simplifié, la Norme canadienne 44-102 – Placement de titres au moyen d’un prospectus préalable, la Norme canadienne 44-103 – Régime de fixation du prix après le visa, la Norme canadienne 45-101 – Placement de droits de souscription, d’échange ou de conversion, la Norme canadienne 51-102 – Obligations d’information continue, la
The Royal Gazette — January 17, 2007
115
Gazette royale — 17 janvier 2007
all of which arose from the repeal of the current version of National Instrument 41-101 – Prospectus Disclosure Requirements.
Norme canadienne 81-101 – Régime de prospectus des organismes de placement collectif, la Norme canadienne 81-104 – Fonds marché à terme et l’Instruction générale canadienne 43-201 – Régime d’examen concerté du prospectus, le tout découlant de l’abrogation de la version courante de la Norme canadienne 41-101 – Renseignements exigés dans les prospectus (NC 41-101).
Introduction On November 27, 2006, the New Brunswick Securities Commission (the Commission) approved publication in order to obtain comments on the proposed NI 41-101 rule and the related consequential amendments arising from the repeal of the current version of NI 41-101.
Introduction Le 27 novembre 2006, la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick (la Commission) autorisa la publication en vue de recueillir des commentaires du projet de règle NC 41-101 ainsi que les modifications corrélatives découlant de l’abrogation de la version courante de la NC 41-101.
Summary of proposed Rule The purpose of the proposed NI 41-101 rule is to create a comprehensive, seamless and transparent set of national prospectus requirements for all issuers including investment funds. The purpose of adopting the consequential amendments is to conform other related national instruments and policies to the proposed Rule. The proposed NI 41-101 Rule is based on three general principles: a) harmonization and consolidation of prospectus requirements across Canada; b) harmonization with other regulatory instruments; and c) reflect current policy. The proposed NI 41-101 rule and the consequential amendments are another step towards harmonizing the prospectus and continuous disclosure requirements across Canada.
Résumé du projet de norme L’objet du projet de règle NC 41-101 est de créer un régime de prospectus exhaustif, homogène et transparent, d’application pancanadienne pour tous les émetteurs, y compris les fonds d’investissement. L’objet des modifications corrélatives est de conformer au projet de règle les règles et les instructions complémentaires canadiennes connexes. Le projet de règle repose sur trois principes généraux :
Request for Comment The Commission seeks comments on the proposed NI 41-101 rule and the related consequential amendments arising from the repeal of the current version of NI 41-101 as they apply to New Brunswick only.
Demande de commentaires La Commission désire prendre connaissance de vos commentaires au sujet du projet de règle NC 41-101 et les modifications corrélatives découlant de l’abrogation de la version courante de la NC 41-101, mais uniquement dans la mesure où cela s’applique au Nouveau-Brunswick.
How to Obtain a Copy and Provide your Comments The text of the relevant materials can be obtained from the Commission’s website at: www.nbsc-cvmnb.ca. Additionally, a paper copy of the relevant materials may be obtained by writing, telephoning or e-mailing the Commission.
Pour nous faire part de vos commentaires On trouvera les textes règlementaires énoncés ci-dessus par l’entremise du site web de la Commission : www.nbsccvmnb.ca. De plus, on peut se procurer un exemplaire sur papier de l’un ou l’autre de ces documents en communiquant par courrier, par téléphone ou par courriel avec la Commission.
Comments are to be provided, in writing, by no later than February 19, 2007 to:
Veuillez nous faire part de vos commentaires par écrit au plus tard le 19 février 2007 à l’adresse suivante :
Secretary New Brunswick Securities Commission 85 Charlotte Street, Suite 300 Saint John, N.B. E2L 2J2 Telephone: 506-658-3060 Toll Free: 1-866-933-2222 (within NB only)
Secrétaire Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick 85, rue Charlotte, bureau 300 Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2B5 Téléphone : 506-658-3060 Sans frais : 1-866-933-2222 (au Nouveau-Brunswick seulement) Télécopieur : 506-658-3059 Courriel :
[email protected]
Fax: 506-658-3059 E-mail:
[email protected]
a)
refonte et harmonisation dans l’ensemble du Canada;
b) harmonisation avec d’autres règles; et c) prise en compte des principes actuels. Le projet de règle NC 41-101 et les modifications corrélatives représentent une avancée supplémentaire vers l’harmonisation des obligations relatives au prospectus et des obligations d’information dans l’ensemble du Canada.
The Royal Gazette — January 17, 2007
If you are not sending your comments by e-mail, please send a diskette containing your comments (PDF or Word). We cannot keep submissions confidential because securities legislation in certain provinces requires that a summary of the written comments received during the comment period be published.
116
Gazette royale — 17 janvier 2007
Si vous n’envoyez pas vos commentaires par courrier électronique, vous devrez nous en faire parvenir une copie sur disquette (Word ou PDF). Nous sommes incapables de garantir la confidentialité des commentaires formulés, étant donné que les mesures législatives sur les valeurs mobilières de certaines provinces exigent que soit publié un résumé des observations écrites qui sont reçues au cours de la période de consultation.
Questions If you have any questions, please refer them to:
Questions Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec la personne suivante :
Kevin Hoyt Director and Chief Financial Officer New Brunswick Securities Commission Telephone: 506-643-7691 E-mail:
[email protected]
Kevin Hoyt Directeur des services financiers généraux et chef des finances Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick Téléphone : 506-643-7691 Courriel :
[email protected]
________________
________________
NOTICE OF RULE NEW BRUNSWICK IMPLEMENTING INSTRUMENT 55-804 (II 55-804) ADOPTING NATIONAL INSTRUMENT 55-102 – SYSTEM FOR ELECTRONIC DISCLOSURE BY INSIDERS (SEDI) (NI 55-102), FORMS 55-102F1, 55-102F2, 55-102F3, 55-102F4, 55-102F5, 55-102F6 (Forms), AND COMPANION POLICY 55-102CP (55-102CP).
AVIS DE RÈGLE NORME DE MISE EN APPLICATION NÉO-BRUNSWICKOISE 55-804 (NMA 55-804) METTANT EN OEUVRE LA NORME CANADIENNE 55-102 – SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE DÉCLARATION DES INITIÉS (SEDI) (NC 55-102), ANNEXES 55-102A1, 55-102A2, 55-102A3, 55-102A4, 55-102A5, 55-102A6, ET L’INSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE 55-102IC (55-102IC).
Ministerial Consent On December 5, 2006, the Minister of Justice consented to the making of II 55-804 adopting NI 55-102, its Forms and 55-102CP.
Consentement ministériel Le 5 décembre 2006, le ministre de la Justice a donné son consentement à l’adoption de la NMA 55-804 mettant en oeuvre la NC 55-102, les annexes et l’Instruction complémentaire 55-102IC.
Summary of Rules NI 55-102 sets out the requirements and procedures relating to the electronic filing of various insider reports, such as Insider Profile, Insider Report, Issuer Profile Supplement, Event Report and User Registration Form. All reporting issuers, with the exception of mutual funds, are subject to the Instrument. They are required to file insider reports within the prescribed timeline and to keep their profile current. There are no filing fees associated with SEDI filings.
Résumé de la règle La NC 55-102 énonce les règles et politiques régissant le dépôt électronique de diverses déclarations d’initiés, notamment le profil d’initié, la déclaration d’initié, le supplément de profil d’émetteur, la déclaration d’opération sur titres et le formulaire d’inscription de l’utilisateur. Le SEDI est destiné aux émetteurs assujettis autres que les fonds communs de placement, et il ne sert pas à percevoir les droits de dépôt.
Effective Date II 55-804 adopting NI 55-102 comes into force on December 29, 2006.
Date d’entrée en vigueur La NMA 55-804 mettant en oeuvre la NC 55-102 est entrée en vigueur le 29 décembre 2006.
How to Obtain a Copy The texts of II 55-804, NI 55-102, its Forms and 55-102CP can be obtained from the Commission’s website: www.nbsccvmnb.ca
Pour obtenir des exemplaires des documents On trouvera les textes de la NMA 55-804, la NC 55-102, les Annexes ainsi que 55-102IC par l’entremise du site Web de la Commission : www.nbsc-cvmnb.ca
A paper copy may be obtained from the Commission by writing, telephoning or e-mailing:
On peut se procurer un exemplaire sur papier de l’un ou l’autre de ces documents en communiquant par courrier, par téléphone ou par courriel avec la Commission :
The Royal Gazette — January 17, 2007
Secretary New Brunswick Securities Commission 85 Charlotte Street, Suite 300 Saint John, N.B. E2L 2J2 Telephone: 506-658-3060 Toll Free: 1-866-933-2222 (within NB only) Fax: 506-658-3059 E-mail:
[email protected]
117
Gazette royale — 17 janvier 2007
Secrétaire Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick 85, rue Charlotte, bureau 300 Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2 Téléphone : 506-658-3060 Sans frais : 1-866-933-2222 (au Nouveau-Brunswick seulement) Télécopieur : 506-658-3059 Courriel :
[email protected]
________________
________________
NOTICE OF RULE NEW BRUNSWICK IMPLEMENTING INSTRUMENT 55-803 (II 55-803) ADOPTING MULTILATERAL INSTRUMENT 55-103 – INSIDER REPORTING FOR CERTAIN DERIVATIVE TRANSACTIONS (EQUITY MONETIZATION) (MI 55-103), AND IMPLEMENTING COMPANION POLICY 55-103CP (55-103CP)
AVIS DE RÈGLE NORME DE MISE EN APPLICATION NÉO-BRUNSWICKOISE 55-803 (NMA 55-803) METTANT EN OEUVRE LA NORME MULTILATÉRALE 55-103 – DÉCLARATIONS D’INITIÉS POUR CERTAINES OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS (MONÉTISATION D’ACTIONS) (NM 55-103) ET L’INSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE 55-103IC (55-103IC).
Ministerial Consent On December 20, 2006, the Minister of Justice consented to the making of II 55-803 adopting MI 55-103 and implementing 55-103CP.
Consentement ministériel Le 20 décembre 2006, le ministre de la Justice a donné son consentement à l’adoption de la NMA 55-803 mettant en oeuvre la NM 55-103 et 55-103IC.
Summary of Rule MI 55-103 reflects a principles-based approach to monetization transactions. If an insider enters into a transaction which satisfies one or more of the policy rationales for insider reporting, but for technical reasons, it may legitimately be argued that the insider falls outside of the existing insider reporting requirements, the insider will be required to file an insider report under MI 55-103. In this way, the market can make its own determination as to the significance, if any, of such arrangements.
Résumé de la règle La NM 55-103 procède, en matière d’opérations de monétisation, d’une optique de principes. L’initié qui conclut une opération répondant à un ou plusieurs des fondements des déclarations d’initiés mais qui pourrait prétendre, pour des raisons d’ordre technique, être exclus du champ d’application des règles en vigueur sera tenu, en vertu de la règle de déposer une déclaration d’initié. Ainsi, le marché pourra juger par soi-même de l’importance éventuelle de l’opération visée.
Effective Date II 55-803 adopting MI 55-103 comes into force on January 2, 2007.
Date d’entrée en vigueur La NMA 55-803 mettant en oeuvre la NM 55-103 et 55-103IC est entrée en vigueur le 2 janvier 2007.
How to Obtain a Copy The texts of II 55-803, MI 55-103 and 55-103CP can be obtained from the Commission’s website: www.nbsc-cvmnb.ca
Pour obtenir des exemplaires des documents On trouvera les textes de la NMA 55-803, la NM 55-103 et 55-103IC par l’entremise du site Web de la Commission : www.nbsc-cvmnb.ca
A paper copy may be obtained from the Commission by writing, telephoning or e-mailing:
On peut se procurer un exemplaire sur papier de l’un ou l’autre de ces documents en communiquant par courrier, par téléphone ou par courriel avec la Commission :
Secretary New Brunswick Securities Commission 85 Charlotte Street, Suite 300 Saint John, N.B. E2L 2J2 Telephone: 506-658-3060 Toll Free: 1-866-933-2222 (within NB only)
Secrétaire Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick 85, rue Charlotte, bureau 300 Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2 Téléphone : 506-658-3060 Sans frais : 1-866-933-2222 (au Nouveau-Brunswick seulement) Télécopieur : 506-658-3059 Courriel :
[email protected]
Fax: 506-658-3059 E-mail:
[email protected]
The Royal Gazette — January 17, 2007
118
Gazette royale — 17 janvier 2007
Notices of Sale
Avis de vente
TO: STEPHANE DOUGLAS ALBERT, of Village Blanchard, in the County of Gloucester, and MARIE RAYMONDE BRIDEAU, of Brantville, in the County of Northumberland, both from the Province of New Brunswick, Mortgagor; and ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN. Freehold property situate at Village Blanchard, in the County of Gloucester and Province of New Brunswick. Notice of sale given by La Caisse Populaire de Caraquet Limitée, Mortgagee. Sale in the lobby of the main entrance of the Caraquet Town Hall, located at 10 Du Colisée Street, Caraquet, in the County of Gloucester and Province of New Brunswick, on Tuesday, February 6, 2007, at 9:00 a.m., local time. See advertisement in L’Acadie Nouvelle.
DESTINATAIRES : STEPHANE DOUGLAS ALBERT, de Village Blanchard, comté de Gloucester, et MARIE RAYMONDE BRIDEAU, de Brantville, comté de Northumberland et tous deux de la province du Nouveau-Brunswick, débiteur hypothécaire; et À TOUTES PERSONNES INTÉRESSÉES. Biens en tenure libre situés à Village Blanchard, dans le comté de Gloucester et la province du Nouveau-Brunswick. Avis de vente est donné par La Caisse Populaire de Caraquet Limitée, créancière hypothécaire. La vente aura lieu au vestibule de l’entrée principale de l’Hôtel de ville de Caraquet, situé au 10, rue du Collisée, Caraquet, comté de Gloucester, province du Nouveau-Brunswick, le mardi, 6 février 2007, à 9 h de l’avant-midi, heure locale. Voir l’annonce publiée dans le journal L’Acadie Nouvelle.
MARCO ROBICHAUD C.P. INC., 8 Du Voilier Street, P.O. Box 5658, Caraquet, N.B. E1W 1B7, Telephone: 506-727-3481, Fax: 506-727-2783, Solicitor for the Mortgagee
MARCO ROBICHAUD C.P. INC., 8, rue du Voilier, C.P. 5658, Caraquet (N.-B) E1W 1B7, téléphone : 506727-3481, télécopieur : 506-727-2783, avocat de la créancière hypothécaire
________________
________________
LINDA GODIN / MARIE LINDA GODIN, of 375 Bois Francs Street, in Saint-Léolin, in the County of Gloucester and Province of New Brunswick, Mortgagor and owner of the equity of redemption; CITIFINANCIAL CANADA EAST CORPORATION, holder of the first Mortgage; and to ALL OTHER WHOM IT MAY CONCERN. Freehold premises situate, lying and being at 375 Bois Francs Street, in Saint-Léolin, in the County of Gloucester and Province of New Brunswick. Notice of Sale is given by the holder of the said first Mortgage.
LINDA GODIN/MARIE LINDA GODIN, du 375, rue Bois Francs, Saint-Léolin, comté de Gloucester, province du Nouveau-Brunswick, débitrice hypothécaire et propriétaire du droit de rachat; CITIFINANCIÈRE, CORPORATION DU CANADA EST, titulaire de la première hypothèque; et TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL. Lieux en tenure libre situés au 375, rue Bois Francs, SaintLéolin, comté de Gloucester, province du Nouveau-Brunswick.
Sale to be held on Wednesday, January 31, 2007, at 11:00 o’clock in the morning, at the Court House located at 254 St. Patrick Street, in Bathurst, in the County of Gloucester and Province of New Brunswick. See advertisement in the newspaper The Northern Light. Dated at Edmundston, New Brunswick, this 2nd day of January, 2007.
Avis de vente donné par la titulaire de ladite première hypothèque. La vente aura lieu le mercredi 31 janvier 2007, à 11 h, au palais de justice situé au 254, rue St. Patrick, Bathurst, comté de Gloucester, province du Nouveau-Brunswick. Voir l’annonce publiée dans le journal The Northern Light. Fait à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, le 2 janvier 2007.
GARY J. McLAUGHLIN, McLaughlin Law Offices, Solicitors and agents for CitiFinancial Canada East Corporation
GARY J. McLAUGHLIN, Cabinet Juridique McLaughlin, avocats et représentants de CitiFinancière, corporation du Canada est
________________
________________
TERRANCE I. HARRIS / ENGLES TERRY HARRIS, of 676 Williamstown Road, at Williamstown, in the County of Northumberland and Province of New Brunswick, Mortgagor and owner of the equity of redemption; MARTHA HARRIS, of the same place, spouse of the Mortgagor; CITIFINANCIAL CANADA EAST CORPORATION, holder of the first Mortgage; and to ALL OTHER WHOM IT MAY CONCERN.
TERRANCE I. HARRIS/ENGLES TERRY HARRIS, du 676, chemin de Williamstown, Williamstown, comté de Northumberland, province du Nouveau-Brunswick, débiteur hypothécaire et propriétaire du droit de rachat; MARTHA HARRIS, du même endroit, conjointe du débiteur hypothécaire; CITIFINANCIÈRE, CORPORATION DU CANADA EST, titulaire de la première hypothèque; et TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.
The Royal Gazette — January 17, 2007
Freehold premises situate, lying and being at of 676 Williamstown Road, at Williamstown, in the County of Northumberland and Province of New Brunswick. Notice of Sale is given by the holder of the said first Mortgage. Sale to be held on Thursday, February 1, 2007, at 11:00 o’clock in the morning, at the Court House located at 673 King George Highway, in Miramichi, in the County of Northumberland and Province of New Brunswick. See advertisement in the newspaper Miramichi Leader. Dated at Edmundston, New Brunswick, this 2nd day of January, 2007.
119
Gazette royale — 17 janvier 2007
Lieux en tenure libre situés au 676, chemin de Williamstown, Williamstown, comté de Northumberland, province du Nouveau-Brunswick. Avis de vente donné par la titulaire de ladite première hypothèque. La vente aura lieu le jeudi 1er février 2007, à 11 h, au palais de justice situé au 673, route King George, Miramichi, comté de Northumberland, province du Nouveau-Brunswick. Voir l’annonce publiée dans le journal Miramichi Leader. Fait à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, le 2 janvier 2007.
GARY J. McLAUGHLIN, McLaughlin Law Offices, Solicitors and agents for CitiFinancial Canada East Corporation
GARY J. McLAUGHLIN, Cabinet Juridique McLaughlin, avocats et représentants de CitiFinancière, corporation du Canada est
________________
________________
PAUL YEE / YOWKWE YEE and JOANNE YEE / HAROLDINE JOANNE YEE, of 27 Brydges Street, in Pointe-du-Chêne, in the County of Westmorland and Province of New Brunswick, Mortgagors and owners of the equity of redemption; CITIFINANCIAL CANADA EAST CORPORATION, holder of the first Mortgage; and to ALL OTHER WHOM IT MAY CONCERN. Freehold premises situate, lying and being at 27 Brydges Street, in Pointe-du-Chêne, in the County of Westmorland and Province of New Brunswick. Notice of sale is given by the holder of the said first Mortgage.
PAUL YEE/YOWKWE YEE et JOANNE YEE/ HAROLDINE JOANNE YEE, du 27, rue Brydges, Pointe-du-Chêne, comté de Westmorland, province du Nouveau-Brunswick, débiteurs hypothécaires et propriétaires du droit de rachat; CITIFINANCIÈRE, CORPORATION DU CANADA EST, titulaire de la première hypothèque; et TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL. Lieux en tenure libre situés au 27, rue Brydges, Pointe-du-Chêne, comté de Westmorland, province du Nouveau-Brunswick. Avis de vente donné par la titulaire de ladite première hypothèque. La vente aura lieu le mercredi 31 janvier 2007, à 10 h, à l’hôtel de ville situé au 655, rue Main, Moncton, comté de Westmorland, province du Nouveau-Brunswick. Voir l’annonce publiée dans le journal Times & Transcript.
Sale to be held on Wednesday, January 31, 2007, at 10:00 o’clock in the morning, at the City Hall located at 655 Main Street, in Moncton, in the County of Westmorland and Province of New Brunswick. See advertisement in the newspaper Times & Transcript. Dated at Edmundston, New Brunswick, this 3rd day of January, 2007.
Fait à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, le 3 janvier 2007.
GARY J. McLAUGHLIN, Q.C., McLaughlin Law Offices, Solicitors and agents for CitiFinancial Canada East Corporation
GARY J. McLAUGHLIN, C.R., Cabinet Juridique McLaughlin, avocats et représentants de CitiFinancière, corporation du Canada est
________________
________________
RICHARD MELVIN BREAU and KAREN ANN ANDERSON, of 63 Sunset Boulevard, at McLeod Hill, in the County of York and Province of New Brunswick, Mortgagors and owners of the equity of redemption; CITIFINANCIAL CANADA EAST CORPORATION, holder of the first Mortgage; and to ALL OTHER WHOM IT MAY CONCERN. Freehold premises situate, lying and being at 63 Sunset Boulevard, at McLeod Hill, in the County of York and Province of New Brunswick. Notice of sale is given by the holder of the said first Mortgage.
RICHARD MELVIN BREAU et KAREN ANN ANDERSON, du 63, boulevard Sunset, McLeod Hill, comté de York, province du Nouveau-Brunswick, débiteurs hypothécaires et propriétaires du droit de rachat; CITIFINANCIÈRE, CORPORATION DU CANADA EST, titulaire de la première hypothèque; et TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL. Lieux en tenure libre situés au 63, boulevard Sunset, McLeod Hill, comté de York, province du Nouveau-Brunswick.
Sale to be held on Wednesday, January 31, 2007, at 11:00 o’clock in the morning, at the Court House located at 427 Queen Street, in Fredericton, in the County of York and Province of New Brunswick. See advertisement in the newspaper The Daily Gleaner.
Avis de vente donné par la titulaire de ladite première hypothèque. La vente aura lieu le mercredi 31 janvier 2007, à 11 h, au palais de justice situé au 427, rue Queen, Fredericton, comté de York, province du Nouveau-Brunswick. Voir l’annonce publiée dans le journal The Daily Gleaner.
The Royal Gazette — January 17, 2007
120
Gazette royale — 17 janvier 2007
Dated at Edmundston, New Brunswick, this 3rd day of January, 2007.
Fait à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, le 3 janvier 2007.
GARY J. McLAUGHLIN, Q.C., McLaughlin Law Offices, Solicitors and agents for CitiFinancial Canada East Corporation
GARY J. McLAUGHLIN, C.R., Cabinet Juridique McLaughlin, avocats et représentants de CitiFinancière, corporation du Canada est
________________
________________
ESTATE OF ARNOLD MacMILLAN and RITA HELEN MacMILLAN, of 4266 Route 114, at Lower Cape, in the County of Albert and Province of New Brunswick, Mortgagors and owners of the equity of redemption; CITIFINANCIAL CANADA EAST CORPORATION, holder of the first Mortgage; and to ALL OTHER WHOM IT MAY CONCERN.
LA SUCCESSION D’ARNOLD MacMILLAN et RITA HELEN MacMILLAN, du 4266, route 114, Lower Cape, comté d’Albert, province du Nouveau-Brunswick, débiteurs hypothécaires et propriétaires du droit de rachat; CITIFINANCIÈRE, CORPORATION DU CANADA EST, titulaire de la première hypothèque; et TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL. Lieux en tenure libre situés au 4266, route 114, Lower Cape, comté d’Albert, province du Nouveau-Brunswick.
Freehold premises situate, lying and being at 4266 Route 114, at Lower Cape, in the County of Albert and Province of New Brunswick. Notice of sale is given by the holder of the said first Mortgage. Sale to be held on Thursday, February 1, 2007, at 11:00 o’clock in the morning, at the Town Hall located at 30 Honour House Street, at Riverview, in the County of Albert and Province of New Brunswick. See advertisement in the newspaper Times & Transcript. Dated at Edmundston, New Brunswick, this 3rd day of January, 2007.
Avis de vente donné par la titulaire de ladite première hypothèque. La vente aura lieu le jeudi 1er février 2007, à 11 h, à l’hôtel de ville situé au 30, rue Honour House, Riverview, comté d’Albert, province du Nouveau-Brunswick. Voir l’annonce publiée dans le journal Times & Transcript. Fait à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, le 3 janvier 2007.
GARY J. McLAUGHLIN, Q.C., McLaughlin Law Offices, Solicitors and agents for CitiFinancial Canada East Corporation
GARY J. McLAUGHLIN, C.R., Cabinet Juridique McLaughlin, avocats et représentants de CitiFinancière, corporation du Canada est
Notice to Advertisers
Avis aux annonceurs
The Royal Gazette is published every Wednesday under the authority of the Queen’s Printer Act. Documents must be received by the Royal Gazette Coordinator, in the Queen’s Printer Office, no later than noon, at least seven days prior to Wednesday’s publication. Each document must be separate from the covering letter. Signatures on documents must be immediately followed by the printed name. The Queen’s Printer may refuse to publish a document if any part of it is illegible, and may delay publication of any document for administrative reasons. Prepayment is required for the publication of all documents. Standard documents have the following set fees:
La Gazette royale est publiée tous les mercredis conformément à la Loi sur l’Imprimeur de la Reine. Les documents à publier doivent parvenir à la coordonnatrice de la Gazette royale, au bureau de l’Imprimeur de la Reine, à midi, au moins sept jours avant le mercredi de publication. Chaque avis doit être séparé de la lettre d’envoi. Les noms des signataires doivent suivre immédiatement la signature. L’Imprimeur de la Reine peut refuser de publier un avis dont une partie est illisible et retarder la publication d’un avis pour des raisons administratives. Le paiement d’avance est exigé pour la publication des avis. Voici les tarifs pour les avis courants :
Notices Notice of the intention to apply for the enactment of a private bill Originating process Order of a court Notice under the Absconding Debtors Act Notice under the General Rules under the Law Society Act, 1996, of disbarment or suspension or of application for reinstatement or readmission
Cost per Insertion $ 20 $ $ $ $
25 25 20 20
Avis Avis d’intention de demander l’adoption d’un projet de loi d’intérêt privé Acte introductif d’instance Ordonnance rendue par une cour Avis exigé par la Loi sur les débiteurs en fuite Avis de radiation ou de suspension ou de demande de réintégration ou de réadmission, exigé par les Règles générales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur le Barreau
Coût par parution 20 $ 25 $ 25 $ 20 $ 20 $
The Royal Gazette — January 17, 2007
121
Notice of examination under the Licensed Practical Nurses Act Notice under the Motor Carrier Act Any document under the Political Process Financing Act
$ 25
Notice to creditors under New Brunswick Regulation 84-9 under the Probate Court Act
$ 20
Notice under the Quieting of Titles Act (Form 70B)
$120
$ 30 $ 20
Note: Survey Maps cannot exceed 8.5″ x 14″
Avis d’examen exigé par la Loi sur les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés Avis exigé par la Loi sur les transports routiers Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur le financement de l’activité politique Avis aux créanciers exigé par le Règlement du NouveauBrunswick 84-9 établi en vertu de la Loi sur la Cour des successions Avis exigé par la Loi sur la validation des titres de propriété
25 $ 30 $ 20 $ 20 $ 120 $
(Formule 70B) Nota : Les plans d’arpentage ne doivent pas dépasser 8,5 po sur 14 po
Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is 1/2 page in length or less
$ 20
Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is greater than 1/2 page in length
$ 75
Any document under the Winding-up and Restructuring Act (Canada) Notice of a correction
$ 20
Any other document
Gazette royale — 17 janvier 2007
charge is the same as for publishing the original document $3.50 for each cm or less
Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces, si l’avis est d’une demi-page ou moins en longueur Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces, si l’avis est de plus d’une demi-page en longueur Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) Avis d’une correction
Tout autre document
20 $ 75 $ 20 $ les frais sont les mêmes que ceux imposés pour la publication du document original 3,50 $ pour chaque cm ou moins
Payments can be made by cash, MasterCard, VISA, cheque or money order (payable to the Minister of Finance). No refunds will be issued for cancellations.
Les paiements peuvent être faits en espèces, par carte de crédit MasterCard ou VISA, ou par chèque ou mandat (établi à l’ordre du ministre des Finances). Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation.
The official version of The Royal Gazette is available free on-line each Wednesday. This free on-line service replaces the printed annual subscription service. The Royal Gazette can be accessed on-line at:
La version officielle de la Gazette royale est disponible gratuitement et en ligne chaque mercredi. Ce service gratuit en ligne remplace le service d’abonnement annuel. Vous trouverez la Gazette royale à l’adresse suivante :
http://www.gnb.ca/0062/gazette/index-e.asp
http://www.gnb.ca/0062/gazette/index-f.asp
Print-on-demand copies of The Royal Gazette are available, at the Office of the Queen’s Printer, at $4.00 per copy plus 14% tax, plus shipping and handling where applicable.
Nous offrons, sur demande, des exemplaires de la Gazette royale, au bureau de l’Imprimeur de la Reine, pour la somme de 4 $ l’exemplaire, plus la taxe de 14 %, ainsi que les frais applicables de port et de manutention.
Office of the Queen’s Printer 670 King Street, Room 117 P.O. Box 6000 Fredericton, NB E3B 5H1 Tel: (506) 453-2520 Fax: (506) 457-7899 E-mail:
[email protected]
Bureau de l’Imprimeur de la Reine 670, rue King, pièce 117 C.P. 6000 Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1 Tél. : (506) 453-2520 Téléc. : (506) 457-7899 Courriel :
[email protected]
QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK
© IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK
All rights reserved / Tous droits réservés