January 17 janvier

5 downloads 9223 Views 193KB Size Report
17 janv. 2007 ... The Royal Gazette is officially published on-line. Except for ... The Hydraulic Shop (2007) Ltd. ... 1993. 08. 27. SUNNY BRAE LAUNDRY & DRY CLEANING LTD. ...... 1994 Saturn SL2, ... 1-800-933-2222 (toll free within New Brunswick) .... conformer au projet de règle les règles et les instructions com-.
The Royal Gazette

Gazette royale

Fredericton New Brunswick

Fredericton Nouveau-Brunswick ISSN 1714-9428

Vol. 165

Wednesday, January 17, 2007 / Le mercredi 17 janvier 2007

Notice to Readers

99

Avis aux lecteurs

The Royal Gazette is officially published on-line.

La Gazette royale est publiée de façon officielle en ligne.

Except for formatting, documents are published in The Royal Gazette as submitted.

Sauf pour le formatage, les documents sont publiés dans la Gazette royale tels que soumis.

Material submitted for publication must be received by the Royal Gazette Coordinator no later than noon, at least 7 working days prior to Wednesday’s publication. However, when there is a public holiday, please contact the Royal Gazette Coordinator.

Les documents à publier doivent parvenir à la coordonnatrice de la Gazette royale, à midi, au moins 7 jours ouvrables avant le mercredi de publication. En cas de jour férié, veuillez communiquer avec la coordonnatrice de la Gazette royale.

Business Corporations Act

Loi sur les corporations commerciales

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of incorporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de constitution en corporation a été émis à :

Name / Raison sociale

Registered Office Bureau enregistré

Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

SEB D GROUP INC.

Dieppe

628331

2007

01

01

Cedar Hills Landscape & Design Ltd.

Saint John

629040

2006

12

31

629324 N.B. Ltd.

Saint John

629324

2006

12

21

629325 N.B. Ltd.

Grand Bay-Westfield

629325

2006

12

21

629326 N.B. Ltd.

Saint John

629326

2006

12

21

The Royal Gazette — January 17, 2007

100

Gazette royale — 17 janvier 2007

Fullerton Farms Ltd.

Long Reach

629327

2007

01

01

LOGAL INC.

Fredericton

629359

2006

12

22

Phoenix Electronic Commerce Systems (Canada) Inc.

Saint John

629361

2006

12

27

Keenan Construction Inc.

Bedell

629362

2006

12

27

CoveredBridge Potato Chip Company Inc.

Woodstock

629363

2006

12

27

THOR’S HOUSE OF THUNDER INC.

Moncton

629364

2006

12

27

Herbal Magic of Quispamsis Inc.

Quispamsis

629366

2006

12

27

629369 N.B. Inc.

Grand-Sault / Grand Falls

629369

2006

12

27

DAE Holdings Ltd.

Somerville

629370

2006

12

27

LINDENWOOD HOLDINGS INC.

Grand-Sault / Grand Falls

629376

2006

12

27

629380 N.B. Inc.

Moncton

629380

2006

12

27

Hazem Assi C.P. Inc.

Moncton

629381

2006

12

27

JCG P.C. Management Inc.

Saint John

629382

2006

12

27

John Gillis Professional Corporation Inc.

Saint John

629383

2006

12

27

RJG Legal Management Inc.

Saint John

629384

2006

12

27

R.J. Gillis, Q.C., PC Inc.

Saint John

629385

2006

12

27

629388 N.B. Ltd.

Moncton

629388

2006

12

28

AHT (FREDERICTON) INC.

Fredericton

629397

2006

12

28

MICRO INNOVATIONS INC.

Moncton

629400

2006

12

28

Walter D. Vail Professional Corporation

Fredericton

629410

2006

12

29

W.D. Vail P.C. Inc.

Fredericton

629411

2006

12

29

629413 N.B. Ltd.

Campbellton

629413

2006

12

29

629418 NEW BRUNSWICK INC.

Miramichi

629418

2006

12

29

The Hydraulic Shop (2007) Ltd.

Saint John

629425

2007

01

01

Doaktown Main St. Gas Bar Inc.

Doaktown

629429

2006

12

29

629430 N.B. Inc.

Moncton

629430

2006

12

29

629431 N.B. Inc.

Moncton

629431

2006

12

29

Jean Knowles Investments Inc.

Lower Newcastle

629433

2006

12

29

CSK Investments Inc.

Lower Newcastle

629439

2006

12

29

Garderie Happy Little Faces Daycare Inc

Beresford

629446

2006

12

29

Basque Property Management Inc.

Moncton

629450

2007

01

01

Drew Simpson Law Office Professional Corporation

Fredericton

629451

2007

01

02

DOKA CANADA LTD./LTEE

Saint John

629457

2007

01

02

Sunrise of Blainville G.P. Inc./ Sunrise de Blainville G.P. Inc.

Saint John

629462

2007

01

02

The Royal Gazette — January 17, 2007

101

Gazette royale — 17 janvier 2007

SZR Blainville Inc.

Saint John

629464

2007

01

02

Chris McCormack Ltd.

Miramichi

629466

2007

01

03

Fownes Manor Inc.

Hillsborough

629470

2007

01

03

Caribou Wind Park GP Limited

Memramcook

629471

2007

01

03

Rockerdale Ventures Limited

Saint John

629472

2007

01

03

Cridland Ventures Limited

Saint John

629473

2007

01

03

629474 N.B. Ltd.

Woodstock

629474

2007

01

03

Denborough Ventures Limited

Saint John

629475

2007

01

03

TRUE STYLE IMPORT INC.

Saint John

629481

2007

01

03

629484 N.B. Inc.

Rothesay

629484

2007

01

03

J. & M. McCarthy Consulting Ltd.

Grand Bay-Westfield

629487

2007

01

04

Inlet Enterprises Ltd.

Moncton

629488

2007

01

04

629491 NB INC.

Edmundston

629491

2007

01

04

_____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of continuance has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de prorogation a été émis à : Previous Jurisdiction Compétence antérieure

Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

Name / Raison sociale

Registered Office Bureau enregistré

Rockville Seiners Limited

Saint John

Nouvelle-Écosse / Nova Scotia

629182

2006

12

15

Rob Porter Holdings Limited

Saint John

Nouvelle-Écosse / Nova Scotia

629183

2006

12

15

ORBCOMM CANADA INC.

Saint John

Canada

629389

2006

12

31

SENTREX WIND SERVICES INC

Quispamsis

Canada

629408

2006

12

29

_____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of amendment has been issued to:

Name / Raison sociale

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de modification a été émis à :

Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

DOLLEMONT’S FUEL & BURNER SERVICE LTD.

005101

2007

01

02

DONNELLY’S ELECTRIC LIMITED

005133

2006

12

28

PINSLER HOLDINGS LTD.

013136

1993

08

27

SUNNY BRAE LAUNDRY & DRY CLEANING LTD.

015752

2007

01

02

S. KNOWLES LTD.

038488

2006

12

29

Jaden Enterprises Ltd.

043601

2006

12

28

The Royal Gazette — January 17, 2007

102

Gazette royale — 17 janvier 2007

I.F. INVESTMENT & PROPERTY LTD.

047961

2006

12

27

ROSS ISLAND SALMON LTD.

053054

2006

12

29

CALEDONIA WASTE-OIL ENTERPRISES LTD.

053677

2007

01

02

CAMCO CONSTRUCTION LTD.

056716

2006

12

28

G.R. BURNETT ENTERPRISES LTD.

500078

2006

12

29

J. KNOWLES HOLDINGS INC.

510797

2006

12

29

054279 N.B. LTD.

619304

2007

01

03

628655 N.B. Inc.

628655

2006

12

29

JCG P.C. Management Inc.

629382

2006

12

28

RJG Legal Management Inc.

629384

2006

12

28

_____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of amendment which includes a change in name has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de modification contenant un changement de raison sociale a été émis à :

Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

Name / Raison sociale

Previous name Ancienne raison sociale

V. N. KHANNA INVESTMENT INC.

V. N. KHANNA PROFESSIONAL CORPORATION

031932

2007

01

02

ENTREPRISES R.E.L. INC.

R.E. LEBLANC CONSULTANTS INC.

050669

2007

01

01

Girvan Auto Leasing Ltd.

Seaside Chevrolet Leasing Ltd.

616268

2007

01

04

Jonart Ventures Limited

Jutsum Ventures Limited

617547

2006

12

29

NORTHWOODS BROADCASTING LIMITED

Radio CJEM Limitée

620659

2007

01

02

BROOKS INDUSTRIES, INC.

C. S. BROOKS WORLD CARPETS, LTD.

621956

2007

01

04

Annan & Bird Lithographers, Inc.

Consolidated Annan & Bird Lithographers, Ltd.

628722

2007

01

03

Ossur Canada Inc.

608745 N.B. Inc.

629142

2007

01

01

SAMMY’S HOLDINGS LTD.

054307 N.B. LTÉE/LTD.

629377

2007

01

01

PLANIFICATION FINANCIÈRE PERSONNALISÉE INC.

628759 N.-B. INC.

629378

2007

01

01

FEDERAL CONSTRUCTION LTD.

628606 N.-B. INC.

629379

2007

01

01

M.C. Ventilation Ltd.

514072 N.B. Ltd.

629394

2007

01

01

Gray Rapids Lumber Company Limited

625980 NB LTD.

629441

2006

12

31

_____________________________________________________

The Royal Gazette — January 17, 2007

103

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of amalgamation has been issued to:

Gazette royale — 17 janvier 2007

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de fusion a été émis à : Reference

Amalgamated Corporation Corporation issue de la fusion

Amalgamating Corporations Corporations fusionnantes

Registered Office Bureau enregistré

Numéro de référence

Number Date Year Month Day année mois jour

Charles W. Read & Associates Ltd.

CHARLES W. READ & ASSOCIATES LTD. 513635 N.B. Ltd.

Fredericton

628952

2006

12

31

WOOD DISABILITY MANAGEMENT INC.

WOOD DISABILITY Bathurst MANAGEMENT INC. WOOD OCCUPATIONAL PLUS INC.

628995

2007

01

01

GESTION C.M. INC.

MÉGA GESTION LTÉE Gestion C.M. Inc. 507189 N.B. INC. 512577 NB Ltée LES ENTREPRISES AMI LIMITÉE

Caraquet

629101

2007

01

01

608745 N.B. Inc.

608745 N.B. Inc. Generation II Orthotics Inc.

Saint John

629142

2007

01

01

Birch Enterprises Ltd.

BIRCH ENTERPRISES LTD. BLUE HOLDINGS LTD.

Moncton

629276

2007

01

01

YVON A. LEBLANC FORESTRY LTD.

YVON A. LEBLANC FORESTRY LTD – LTEE 613031 N.B. INC.- 613031 N.-B. INC.

McKees Mills

629299

2006

12

31

LORNE BRETT MOTORS LTD.

LORNE BRETT MOTORS LTD. 629301 N.B. INC.

Saint John

629302

2006

12

31

ROBICHAUD MANAGEMENT LIMITÉE

J. V. ROBICHAUD ET FILS LIMITEE Shippagan - J. V. ROBICHAUD & SONS LIMITED ROBICHAUD MANAGEMENT LIMITEE

629305

2007

01

01

JCW HOLDINGS INC.

JCW HOLDINGS INC. 628966 N.B. Ltd.

Fredericton

629311

2007

01

01

Maritime Hydroseed (1988) Ltd.

MARITIME HYDROSEED (1988) LTD. 607077 N.B. Inc.

Saint John

629312

2007

01

01

627696 N.B. Ltd.

059418 N.B. LTD. 627696 N.B. Ltd.

Moncton

629316

2007

01

01

Gaudet Saulnier Assurance Ltée

GAUDET SAULNIER ASSURANCE LTÉE 624004 N.B. Inc.

Memramcook

629347

2007

01

01

K.C.R. Fisheries Ltd.

FUNDY SURF FISHERIES LTD. GEORGE JOHNSON & SONS FISHERIES LTD. C & R FISHERIES LTD. R.S. & T. FISHERIES LTD. LINTON BROS. FISHERIES LTD. K.C.R. FISHERIES LTD. 607008 N.B. LTD. Rockville Seiners Limited Rob Porter Holdings Limited

Saint John

629356

2007

01

01

Beckelm Farm Ltd.

BECKELM FARM LTD. 629129 N.B. Ltd.

Second North River

629371

2007

01

01

The Royal Gazette — January 17, 2007

104

Gazette royale — 17 janvier 2007

Eedda Capital Inc.

ADDEE DEVELOPMENTS LIMITED Rothesay EEDDA CAPITAL INC. 628049 N.B. Ltd.

629372

2007

01

01

LECLERC HOLDINGS INC.

LECLERC HOLDINGS INC. 513511 N.-B. INC.

Grand-Sault / Grand Falls

629373

2007

01

01

PAUL & ANDRÉ LTÉE

PAUL & ANDRÉ LTÉE 507211 N.-B. INC. MIC VON INC.

Grand-Sault / Grand Falls

629374

2007

01

01

DOOLY’S INC.

DOOLY’S WOODSTOCK INC. DOOLY’S GRAND-SAULT INC. DOOLY’S INC.

Moncton

629375

2006

12

30

054307 N.B. LTÉE/LTD.

Sammy’s Holdings Ltd. 054307 N.B. LTEE/LTD.

Bathurst

629377

2007

01

01

628759 N.-B. INC.

PLANIFICATION FINANCIERE PERSONNALISÉE INC. 628759 N.-B. INC.

Beresford

629378

2007

01

01

628606 N.-B. INC.

FEDERAL CONSTRUCTION LTD. 628606 N.-B. Inc.

Petit-Rocher Ouest / West

629379

2007

01

01

ORBCOMM CANADA INC.

ORBCOMM Canada Corp. ORBCOMM CANADA INC.

Saint John

629390

2006

12

31

040774 N.B. Ltd.

THIRTY-FIVE CHARLOTTE LTD. 040774 N.B. Ltd.

Rothesay

629391

2007

01

01

Coast Tire & Auto Service Ltd.

Versatile Powder Coating Inc. Coast Tire & Auto Service Ltd.

Saint John

629392

2007

01

01

514072 N.B. Ltd.

MC VENTILATION LTD. 514072 N.B. Ltd.

Saint John

629394

2007

01

01

PA. PE. JE. HOLDINGS LTD.

PA. PE. JE. HOLDINGS LTD. BURGESS TRAVEL LIMITED

Saint John

629395

2006

12

31

REOCO Limited

503402 N.B. INC. Saint John KINGSTON ROAD HOLDINGS N.B. INC. SEVEN CHALEUR INC. MERIVALE GENERAL CORPORATION REOCO MANNING GP CORP. REOCO Limited 506912 N.B. Inc.

629396

2007

01

01

ALLIANCE ASSURANCE HOLDING INC. Five Leaf Inc. ALLIANCE ASSURANCE HOLDING INC.

Grand-Sault / Grand Falls

629398

2007

01

02

Silver Falls Park Development Company Limited

H. C. MCNAMARA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED SILVER FALLS PARK DEVELOPMENT COMPANY LIMITED HALMAC HOLDINGS LTD.

Saint John

629406

2007

01

01

AB Miles Ltd.

AB MILES LTD. 050690 N.B. LTD.

Esteys Bridge

629424

2006

12

29

The Royal Gazette — January 17, 2007

105

Gazette royale — 17 janvier 2007

SITTHE CANADA LTD.

CARDINAL INVESTORS, INC. SITHE ENERGIES CANADA POWER SERVICES INC. Sithe Southdown, Ltd. SITHE CANADIAN PIPELINES LTD. SITHE SOUTHDOWN PIPELINES LTD. 609371 N.B. Ltd. SITHE CANADA LTD. 616891 N.B. INC.

Saint John

629434

2007

01

01

SITHE CANADIAN HOLDINGS INC.

SITHE CANADIAN HOLDINGS INC. Saint John SITTHE CANADA LTD.

629435

2007

01

01

HAZELHURST HOLDINGS LTD.

Hazelhurst Holdings Ltd. 617193 N.B. INC.

Saint John

629436

2007

01

01

SITHE CANADIAN HOLDINGS INC.

SITHE CANADIAN HOLDINGS INC. Saint John HAZELHURST HOLDINGS LTD.

629437

2007

01

01

625980 NB LTD.

GRAY RAPIDS LUMBER COMPANY LIMITED 625980 NB LTD.

629441

2006

12

31

Jacksonville

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of dissolution has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de dissolution a été émis à : Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

Name / Raison sociale

Registered Office Bureau enregistré

IRP GATEWAY INC.

Saint John

506884

2006

12

29

Sithe Energies Canadian Development, Ltd.

Saint John

508409

2006

12

22

36 Adelaide General Corporation

Saint John

509612

2006

12

29

TECH PARK GENERAL CORPORATION

Saint John

510451

2006

12

29

MANNING INDUSTRIAL PROPERTIES CORPORATION

Saint John

512509

2006

12

29

MANNING SHOPPING CENTRE CORPORATION

Saint John

512510

2006

12

29

IRP MANNING (NB) CORP.

Saint John

512572

2006

12

29

THE GREAT PLANT COMPANY INC./ LA COMPAGNIE GREAT PLANT INC.

Saint John

516100

2006

12

29

_____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of discontinuance has been issued to:

Name / Raison sociale

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de cessation a été émis à :

Jurisdiction of Continuance Compétence de prorogation

Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

TRI-HOLDINGS LTD.

Colombie-Britannique / British Colombia

016371

2006

12

22

DH CANADA INC.

Nouvelle-Écosse / Nova Scotia

506281

2006

12

19

_____________________________________________________

The Royal Gazette — January 17, 2007

106

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of revival has been issued to:

Gazette royale — 17 janvier 2007 SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de reconstitution a été émis à : Date Year Month Day année mois jour

Reference Number Numéro de référence

Name / Raison sociale

KILLAM DRIVE SURPLUS CENTRE LTD.

037326

2006

12

08

_____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of registration of extra-provincial corporation has been issued to:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat d’enregistrement de corporation extraprovinciale a été émis à : Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

Name / Raison sociale

Jurisdiction Compétence

Agent and Address Représentant et adresse

WESTON FOODS (CANADA) INC.

Ontario

Walter D. Vail Fredericton

629149

2006

12

14

OLYMPIC MOTORS CORPORATION

Canada

Peter Wright Moncton

629259

2006

12

19

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS CANADA INC. PRODUITS D’INGÉNIERIE GOODYEAR CANADA INC.

Canada

Donald MacGowan Saint John

629281

2006

12

20

Latin American Minerals Inc.

Canada

SMSS Corporate Services (NB) Inc. Saint John

629350

2006

12

22

Creststreet 2007 General Partner Limited/ Ontario Commandite Creststreet 2007 Limitee

SMSS Corporate Services (NB) Inc. Saint John

629403

2006

12

29

VALLEY TRUSS & METAL LTD.

Susan K. Layton Saint John

629404

2006

12

29

Ontario

_____________________________________________________ PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of amendment of registration of extraprovincial corporation has been issued to:

Name / Raison sociale

4304853 CANADA INC.

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat de modification de l’enregistrement de corporation extraprovinciale a été émis à :

Previous name Ancienne raison sociale

Reference Number Numéro de référence

COMPAGNIE DE CONSTRUCTION 619981 DE PIPELINES BANISTER INC. BANISTER PIPELINE CONSTRUCTION INC. _____________________________________________________

Date Year Month Day année mois jour

2006

12

20

The Royal Gazette — January 17, 2007

107

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Business Corporations Act, a certificate of registration of amalgamated corporation has been issued to the following extra-provincial corporations:

Amalgamated Corporation Corporation issue de la fusion

Amalgamating Corporations Corporations fusionnantes

BIOGENIE S.R.D.C. INC.

Biogenie S.R.D.C. Inc.

Gazette royale — 17 janvier 2007 SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les corporations commerciales, un certificat d’enregistrement d’une corporation extraprovinciale issue de la fusion a été émis aux corporations extraprovinciales suivantes : Agent and Address Représentant et adresse

John D. Larlee Fredericton

Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

629438

2006

12

28

Partnerships and Business Names Registration Act

Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of business name has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat d’appellation commerciale a été enregistré :

Registrant of Certificate Enregistreur du certificat

Address of Business or Agent Adresse du commerce ou du représentant

Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

T. ENGLISH ENTERPRISES

Ted English

Moncton

629146

2006

12

14

Airtech Consulting Services

Lisa Hutchings

Moncton

629147

2006

12

14

Assurance Beausejour Gaudet INSURANCE

ASSURANCE BEAUSEJOUR

Dieppe

629178

2006

12

15

FEDERAL PROTECTIVE SERVICES (FPS)

Robert W. Sabine

Saint John

629180

2006

12

15

Salon Top Chic

Mélanie B. Thibodeau

Edmundston

629206

2006

12

18

Country Quilt Finishing

Wendy Billing

Greater Lakeburn

629214

2006

12

18

D & S Smith Salvage and Sales

Danny Smith

Woodstock

629216

2006

12

18

Clinical Massage Group

Peter Simpson

Moncton

629260

2006

12

18

Countertop Creations

COUNTERTOPS PLUS LTD.

Moncton

629261

2006

12

19

Marsh’s Private Client Service

MARSH CANADA LIMITED/ MARSH CANADA LIMITÉE

Saint John

629329

2007

01

01

Services aux particuliers de Marsh

MARSH CANADA LIMITED/ MARSH CANADA LIMITÉE

Saint John

629330

2007

01

01

Location Crédit Ford Canada

CANADIAN ROAD LEASING COMPANY/COMPAGNIE DE LOCATION CANADIAN ROAD

Saint John

629337

2007

01

01

Location Crédit Jaguar Canada

CANADIAN ROAD LEASING COMPANY/COMPAGNIE DE LOCATION CANADIAN ROAD

Saint John

629338

2007

01

01

Location Services financiers Land Rover

CANADIAN ROAD LEASING COMPANY/COMPAGNIE DE LOCATION CANADIAN ROAD

Saint John

629339

2007

01

01

Name / Raison sociale

The Royal Gazette — January 17, 2007

108

Gazette royale — 17 janvier 2007

Location Crédit Mazda Canada

CANADIAN ROAD LEASING COMPANY/COMPAGNIE DE LOCATION CANADIAN ROAD

Saint John

629340

2007

01

01

Location Services financiers Auto. Volvo

CANADIAN ROAD LEASING COMPANY/COMPAGNIE DE LOCATION CANADIAN ROAD

Saint John

629341

2007

01

01

Location Services financiers Automobiles Volvo du Canada

CANADIAN ROAD LEASING COMPANY/COMPAGNIE DE LOCATION CANADIAN ROAD

Saint John

629342

2007

01

01

Restorative Muscle Care

Sherry Robichaud

Riverview

629348

2006

12

22

Bijouterie Celebrite Jewellers (2007) SLC

Stephanie Chamberlain

Bathurst

629354

2007

01

01

Olynyks Carpentry

David Igor Olynyk

Riverview

629360

2006

12

27

FNC & Associates

Vincent Larry

Eel Ground

629365

2006

12

27

Easy Lawn Hydroseeding

John Fraser

Rothesay

629367

2006

12

27

Blaney Cycle Supply

Barry Blaney

Nortondale

629387

2006

12

28

Versatile Powder Coating

Coast Tire & Auto Service Ltd.

Saint John

629393

2007

01

01

CANOAK-SPORT.COM

Guy Gino Roy

Shippagan

629401

2006

12

28

GAMES R US

Aaron Jeremy Gates

Saint John

629405

2006

12

29

R.E. LEBLANC CONSULTANTS

628056 NB INC.

Moncton

629407

2006

12

27

Desperado Chop Shop

Matt Sturgeon

New Maryland

629440

2006

12

29

Gauvis Scrap Metal Removal

Serge Gauvin

Cocagne

629447

2006

12

29

Hoffmann Design

John Hoffmann

Mazerolle Settlement

629449

2007

01

01

DNR Jewellery Exchange

David Rule

Riverview

629463

2007

01

02

Haddad Marketing

Thomas David Haddad

Moncton

629465

2007

01

02

WWWA Wholesale

Warren Whittle

Moncton

629467

2007

01

03

Bathurst Mortgage Center/ Centre Hypothécaire Bathurst

Amédée Haché

Bathurst

629468

2007

01

03

Pisces Restaurant

Gaston Frigault

Moncton

629469

2007

01

03

Stewart Heavy Equipment Contracting & Rentals

Christopher W. Stewart

Miramichi

629485

2007

01

03

Melvin’s Cafeteria

Debra Melvin

Saint John

629490

2007

01

04

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of renewal of business name has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de renouvellement d’appellation commerciale a été enregistré :

Name / Raison sociale

Registrant of Certificate Enregistreur du certificat

Address of Business or Agent Adresse du commerce ou du représentant

Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

CLIFF’S DRIVER TRAINING

Clifford C. Hodgin

Sussex

339700

2006

12

30

Bowlarama @ 2020

Lockmac Holdings Limited

Bathurst

352235

2007

01

02

The Royal Gazette — January 17, 2007

109

Gazette royale — 17 janvier 2007

La Zone

Lockman Holdings Limited

Bathurst

352236

2007

01

02

RIVER HAVEN CAMPGROUND

Richard Stephen Matheson

Tabusintac

352797

2007

01

02

Trevors Hyundai

RAE’S TRAILER & SPORTS CENTER LTD.

Miramichi

352981

2006

12

27

Dia Care Diabetes Education And Consultation Services

Shelley L. Jones

Salisbury

353037

2006

12

27

Concept Communications

INVESTO INC.

Dieppe

353065

2006

12

31

CustomerWorks

CustomerWorks Limited Partnership

Fredericton

353145

2006

12

14

PENTARUS GRAPHICS

Jeffrey D. McPhee

Moncton

353200

2007

01

03

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of cessation of business or use of business name has been registered:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de cessation de l’activité ou de cessation d’emploi de l’appellation commerciale a été enregistré : Address / Adresse

Name / Raison sociale

Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

MARSH PRIVATE CLIENT SERVICES/ SERVICE D’ASSURANCE PRIVILÉGIÉ MARSH

Saint John

347095

2007

01

01

By The Web Services

Riverview

351447

2007

01

03

FULLERTON FARMS

Long Reach

608839

2006

12

31

Cedar Hills Landscape & Design

Saint John

623904

2006

12

31

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of partnership has been registered:

Name / Raison sociale

Partners / Membres

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de société en nom collectif a été enregistré : Address of Business or Agent Adresse du commerce ou du représentant

Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

GE CANADA VEHICLE & EQUIPMENT SERVICES/ GE CANADA SERVICES DE LOCATION DE VÉHICULES ET D’ÉQUIPEMENT

General Electric Capital Canada/ Capital Generale Electrique du Canada GE Canada Vel Services Company

Saint John

629209

2006

12

18

SHELL CANADA ENERGY

SHELL CANADA LIMITED SHELL CANADA LIMITEE BlackRock Ventures Inc. 6581528 Canada Ltd.

Fredericton

629285

2007

01

01

_____________________________________________________

The Royal Gazette — January 17, 2007

110

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of dissolution of partnership has been registered:

Gazette royale — 17 janvier 2007

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de dissolution de société en nom collectif a été enregistré : Address / Adresse

Name / Raison sociale

D & S Smith Salvage and Sales

Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

628862

2006

Woodstock

12

18

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Partnerships and Business Names Registration Act, a certificate of change of membership of partnership has been registered:

Name / Raison sociale

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, un certificat de changement d’associé d’une société en nom collectif a été enregistré :

Retiring Partners Associés sortants

Incoming Partners Nouveaux associés

Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

LE Groupe Zarico

Serge Leblanc

353345

2006

12

11

Imex Universal Trading

Osoma Al Masri

621907

2006

12

04

Point Click Media Productions

Marc Godin

625839

2006

12

04

Limited Partnership Act

Loi sur les sociétés en commandite

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partnership Act, a declaration of extra-provincial limited partnership has been filed:

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une déclaration de société en commandite extraprovinciale a été déposée par :

Name / Raison sociale

Principal place in New Brunswick Principal établissement au Nouveau-Brunswick

ITT Canada Trading L.P.

Saint John

Ontario

SMSS Corporate Services (NB) Inc. Saint John

629177

2006

12

15

ENERVEST FTS LIMITED PARTNERSHIP 2006 II

Saint John

Alberta

SMSS Corporate Services (NB) Inc. Saint John

629280

2006

12

20

NCE DIVERSIFIED FLOWTHROUGH (07) LIMITED PARTNERSHIP

Saint John

Ontario

SMSS Corporate Services (NB) Inc. Saint John

629306

2006

12

21

Norrep Performance 2007 Flow-Through (07) Limited Partnership

Saint John

Ontario

SMSS Corporate Services (NB) Inc. Saint John

629453

2006

12

29

Jurisdiction Compétence

Agent and Address Représentant et adresse

Reference Number Numéro de référence

Date Year Month Day année mois jour

The Royal Gazette — January 17, 2007 Creststreet 2007 Limited

111 Saint John

Ontario

Gazette royale — 17 janvier 2007 SMSS Corporate Services (NB) Inc. Saint John

629454

2006

12

29

_____________________________________________________

PUBLIC NOTICE is hereby given that under the Limited Partnership Act, a declaration of withdrawal of extra-provincial limited partnership has been filed:

Name / Raison sociale

Jurisdiction Compétence

Precision Limited Partnership

Alberta

SACHEZ qu’en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, une déclaration de retrait de société en commandite extraprovinciale a été déposée par : Agent and Address Représentant et adresse

SMMS Corporate Services (NB) Inc. Saint John

Reference Number Numéro de référence

400608

Date Year Month Day année mois jour

2006

12

14

Department of Public Safety

Ministère de la Sécurité publique

SALE OF MOTOR VEHICLES Take notice that the Registrar of Motor Vehicles, Province of New Brunswick will be disposing of the following vehicles on or after January 17, 2007: 1994 Oldsmobile Cierra, Serial No. 1G3NL53MXRM019329 License Plate: GNE089 Registered Owner: Phillipe Gigou Vehicle located at George’s Towing, Shediac

VENTE DE VÉHICULES À MOTEUR Sachez que le registraire des véhicules à moteur de la province du Nouveau-Brunswick mettra en vente les véhicules à moteur suivants le 17 janvier 2007 : Oldsmobile Cierra 1994, numéro de série : 1G3NL53MXRM019329 Numéro d’immatriculation : GNE089 Propriétaire immatriculée : Phillipe Gigou Véhicule se trouvant actuellement chez George’s Towing, Shediac Mercury Topaz 1994, numéro de série : 1MEBM36X9RK614323 Numéro d’immatriculation : BQN367 Propriétaire immatriculée : Daniel Gautreau Véhicule se trouvant actuellement chez George’s Towing, Shediac Nissan Sentra 1994, numéro de série : 3N1EB32S0RL003290 Numéro d’immatriculation : GPH612 Propriétaire immatriculée : Khalid El Idrissi Véhicule se trouvant actuellement chez George’s Towing, Shediac Pontiac Sunbird 1991, numéro de série : 1G2JB51K8M7625078 Numéro d’immatriculation : 828RYW Propriétaire immatriculée : Huguette Hebert Véhicule se trouvant actuellement chez George’s Towing, Shediac Pontiac 6000 1990, numéro de série : 1G2AF51T3L6237306 Numéro d’immatriculation : GLF924 Propriétaire immatriculée : Lorraine Mallet Véhicule se trouvant actuellement chez George’s Towing, Shediac

1994 Mercury Topaz, Serial No. 1MEBM36X9RK614323 License Plate: BQN367 Registered Owner: Daniel Gautreau Vehicle located at George’s Towing, Shediac 1994 Nissan Sentra, Serial No. 3N1EB32S0RL003290 License Plate: GPH612 Registered Owner: Khalid El Idrissi Vehicle located at George’s Towing, Shediac 1991 Pontiac Sunbird, Serial No. 1G2JB51K8M7625078 License Plate: 828RYW Registered Owner: Huguette Hebert Vehicle located at George’s Towing, Shediac 1990 Pontiac 6000, Serial No. 1G2AF51T3L6237306 License Plate: GLF924 Registered Owner: Lorraine Mallet Vehicle located at George’s Towing, Shediac

The Royal Gazette — January 17, 2007

112

Gazette royale — 17 janvier 2007

1992 Chevrolet Cavalier, Serial No. 3G1JC1149NS819505 License Plate: BKU270 Registered Owner: Donald Nowlan Vehicle located at George’s Towing, Shediac

Chevrolet Cavalier 1992, numéro de série : 3G1JC1149NS819505 Numéro d’immatriculation : BKU270 Propriétaire immatriculée : Donald Nowlan Véhicule se trouvant actuellement chez George’s Towing, Shediac

1997 Chrysler Intrepid, Serial No. 2C3HH46T3VH677667 License Plate: BUC892 Registered Owner: Thomas Atwin Vehicle located at Kitchen’s Auto Body Repair

Chrysler Intrepid 1997, numéro de série : 2C3HH46T3VH677667 Numéro d’immatriculation : BUC892 Propriétaire immatriculée : Thomas Atwin Véhicule se trouvant actuellement chez Kitchen’s Body Repair Cadillac DeVille 1988, numéro de série : 1G6CD1159J4239206 Numéro d’immatriculation : GMH061 Propriétaire immatriculée : Eric Fraser Véhicule se trouvant actuellement chez Kitchen’s Body Repair Mercury Topaz 1994, numéro de série : 1MEBM31X4RK609229 Numéro d’immatriculation : GBW281 Propriétaire immatriculée : Raymond Ryan Véhicule se trouvant actuellement chez Kitchen’s Body Repair Mazda Protégé 1999, numéro de série : JM1BJ2220X0152094 Numéro d’immatriculation : AMSJ356 Propriétaire immatriculée : Sean Foley Véhicule se trouvant actuellement chez Kitchen’s Body Repair Plymouth Acclaim 1993, numéro de série : 3P3XA46K7PT622927 Numéro d’immatriculation : BQG416 Propriétaire immatriculée : Merton A. Jewett Véhicule se trouvant actuellement chez Kitchen’s Body Repair Pontiac Grand Am 1995, numéro de série : 1G2NE53M0SM607700 Numéro d’immatriculation : BSO621 Propriétaire immatriculée : Loretta Sabattis Véhicule se trouvant actuellement chez Kitchen’s Body Repair

1988 Cadillac DeVille, Serial No. 1G6CD1159J4239206 License Plate: GMH061 Registered Owner: Eric Fraser Vehicle located at Kitchen’s Auto Body Repair 1994 Mercury Topaz, Serial No. 1MEBM31X4RK609229 License Plate: GBW281 Registered Owner: Raymond Ryan Vehicle located at Kitchen’s Auto Body Repair 1999 Mazda Protégé, Serial No. JM1BJ2220X0152094 License Plate: AMSJ356 Registered Owner: Sean Foley Vehicle located at Kitchen’s Auto Body Repair 1993 Plymouth Acclaim, Serial No. 3P3XA46K7PT622927 License Plate: BQG416 Registered Owner: Merton A. Jewett Vehicle located at Kitchen’s Auto Body Repair 1995 Pontiac Grand Am, Serial No. 1G2NE53M0SM607700 License Plate: BSO621 Registered Owner: Loretta Sabattis Vehicle located at Kitchen’s Auto Body Repair 1989 Honda Civic, Serial No. 2HGEJ6513XH916623 License Plate: BZJ315 Registered Owner: Nicole Leger Vehicle located at Loftus Auto, Moncton 1989 Mercury Grand, Serial No. 2MEBM74F9KX692914 License Plate: BBU310 Registered Owner: Mack Bear Vehicle located at Loftus Auto, Moncton

Auto

Auto

Auto

Auto

Auto

Auto

Honda Civic 1989, numéro de série : 2HGEJ6513XH916623 Numéro d’immatriculation : BZJ315 Propriétaire immatriculée : Nicole Leger Véhicule se trouvant actuellement chez Loftus Auto, Moncton Mercury Grand 1989, numéro de série : 2MEBM74F9KX692914 Numéro d’immatriculation : BBU310 Propriétaire immatriculée : Mack Bear Véhicule se trouvant actuellement chez Loftus Auto, Moncton

The Royal Gazette — January 17, 2007

1994 Saturn SL2, Serial No. 1G8ZJ5576RZ240499 License Plate: GPD559 Registered Owner: Monique Thebeau Vehicle located at Loftus Auto, Moncton

113

Gazette royale — 17 janvier 2007

Saturn SL2 1994, numéro de série : 1G8ZJ5576RZ240499 Numéro d’immatriculation : GPD559 Propriétaire immatriculée : Monique Thebeau Véhicule se trouvant actuellement chez Loftus Auto, Moncton

Service New Brunswick

Services Nouveau-Brunswick

Public notice of change of registered name under the Change of Name Act, chapter C-2.001, s.9(1.1) of the acts of New Brunswick, 1987

Avis public de changement de noms enregistrés en application de la Loi sur le changement de nom, lois du Nouveau-Brunswick de 1987, c.C-2.001, art.9(1.1)

Previous Registered Name: Robert William Palmer Delancey Abdullah Robert Delancey New Registered Name: 22 Seventh Street Address: Moncton, N.B. E1E 3G1 November 28, 2006 Date Granted:

Ancien nom enregistré :

Previous Registered Name: Bernhard Alexander Dütz New Registered Name: Lone Wolf Address: 540 Route 103 Woodstock, N.B. E7M 6B6 December 13, 2006 Date Granted:

Ancien nom enregistré : Nouveau nom enregistré : Adresse :

Previous Registered Name: Christopher Richard Francis Kolacz New Registered Name: Christopher Richard Francis Kolaczan 161 Main Street, Apt. #1 Address: Fredericton, N.B. E3A 1C6 December 15, 2006 Date Granted:

Ancien nom enregistré :

Previous Registered Name: Marie Apauline Durelle New Registered Name: Pauline Marie Apolline Durelle Address: 35 W. Gay Néguac, N.B. E9G 1Z2 January 2, 2007 Date Granted:

Ancien nom enregistré : Nouveau nom enregistré : Adresse :

Previous Registered Name: Joseph Denis Bélanger Gaétan Bélanger New Registered Name: 78, rue Beaurivage N. Address: Ste-Florence, Québec G0J 2M0 January 3, 2007 Date Granted:

Ancien nom enregistré : Nouveau nom enregistré : Adresse :

Josée Dubé Acting Registrar General of Vital Statistics

Robert William Palmer Delancey Nouveau nom enregistré : Abdullah Robert Delancey Adresse : 22, rue Seventh Moncton (N.-B.) E1E 3G1 Date d’accueil de la demande : Le 26 novembre 2006 Bernhard Alexander Dütz Lone Wolf 540, route 103 Woodstock (N.-B.) E7M 6B6 Date d’accueil de la demande : Le 13 décembre 2006 Christopher Richard Francis Kolacz Nouveau nom enregistré : Christopher Richard Francis Kolaczan 161, rue Main, app. #1 Adresse : Fredericton (N.-B.) E3A 1C6 Date d’accueil de la demande : Le 15 décembre 2006 Marie Apauline Durelle Pauline Marie Apolline Durelle 35 W. Gay Néguac (N.-B.) E9G 1Z2 Date d’accueil de la demande : Le 2 janvier 2007 Joseph Denis Bélanger Gaétan Bélanger 78, rue Beaurivage N. Ste-Florence (Québec) G0J 2M0 Date d’accueil de la demande : Le 3 janvier 2007 Josée Dubé Registraire générale des statistiques de l’état civil par intérim

The Royal Gazette — January 17, 2007

114

Gazette royale — 17 janvier 2007

New Brunswick Securities Commission

Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick

NOTICE OF AMENDMENT TO BY-LAW NO. 1 Pursuant to subsection 22(4) of the Securities Act. 1) Title By-Law No. 1 – General Business Affairs – amendment to Article 3.1

AVIS DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 1 Sous le régime du paragraphe 22(4) de la Loi sur les valeurs mobilières 1) Titre Modification du paragraphe 3.1 du Règlement administratif no 1 sur la conduite générale des affaires

2) Substance of amendment The Commission has amended Article 3.1 to make provision for an annual retainer of $2,000 for the Lead Member and chairs of committees.

2) Teneur de la modification La Commission a modifié le paragraphe 3.1 du règlement administratif afin qu’une provision annuelle de 2 000 $ puisse être versée au membre principal et aux présidents de comité.

3) Date of coming into force: 1 January 2007

3) Date d’entrée en vigueur Le 1er janvier 2007

4) To obtain a copy of the by-law: By-Law No. 1 is available on the Commission website at www.nbsc-cvmb.ca

4) Comment obtenir un exemplaire du règlement Le règlement administratif no 1 se trouve dans le site Web de la Commission : www.nbsc-cvmb.ca

A paper copy may be obtained:

Il est possible de s’en procurer un exemplaire sur papier

in writing: Secretary New Brunswick Securities Commission 300-85 Charlotte Street Saint John, New Brunswick E2L 2J2

par écrit : Secrétaire Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick 85, rue Charlotte, bureau 300 Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2

by telephone: 1-800-933-2222 (toll free within New Brunswick) 506-658-3060 (outside New Brunswick) 506-658-3059 (fax your request)

par téléphone : 1-800-933-2222 (sans frais au Nouveau-Brunswick) 506-658-3060 (de l’extérieur du Nouveau-Brunswick) 506-658-3059 (télécopieur)

by email: [email protected]

par courriel : [email protected]

________________

________________

REQUEST FOR COMMENT Notice and Request for Comment – Publishing for comment proposed National Instrument 41-101 – General Prospectus Requirements (the proposed NI 41-101 rule), resulting in consequential amendments to National Instrument 14-101 – Definitions, National Instrument 44-101 – Short Form Prospectus Distributions, National Instrument 44-102 – Shelf Distributions, National Instrument 44-103 – Post-Receipt Pricing, National Instrument 45-101 – Rights Offerings, National Instrument 51-102 – Continuous Disclosure Obligations, National Instrument 81-101 – Mutual Fund Prospectus Disclosure, National Instrument 81-104 – Commodity Pools, and National Policy 43-201 – Mutual Reliance Review System for Prospectuses,

DEMANDE DE COMMENTAIRES Avis de consultation et demande de commentaires – Publication en vue de recueillir des commentaires au sujet du projet de règle relative à la Norme canadienne 41-101 – Obligations générales relatives au prospectus (projet de règle NC 41-101), qui mena à des modifications corrélatives à la Norme canadienne 14-101 – Définitions, la Norme canadienne 44-101 – Placement de titres au moyen d’un prospectus simplifié, la Norme canadienne 44-102 – Placement de titres au moyen d’un prospectus préalable, la Norme canadienne 44-103 – Régime de fixation du prix après le visa, la Norme canadienne 45-101 – Placement de droits de souscription, d’échange ou de conversion, la Norme canadienne 51-102 – Obligations d’information continue, la

The Royal Gazette — January 17, 2007

115

Gazette royale — 17 janvier 2007

all of which arose from the repeal of the current version of National Instrument 41-101 – Prospectus Disclosure Requirements.

Norme canadienne 81-101 – Régime de prospectus des organismes de placement collectif, la Norme canadienne 81-104 – Fonds marché à terme et l’Instruction générale canadienne 43-201 – Régime d’examen concerté du prospectus, le tout découlant de l’abrogation de la version courante de la Norme canadienne 41-101 – Renseignements exigés dans les prospectus (NC 41-101).

Introduction On November 27, 2006, the New Brunswick Securities Commission (the Commission) approved publication in order to obtain comments on the proposed NI 41-101 rule and the related consequential amendments arising from the repeal of the current version of NI 41-101.

Introduction Le 27 novembre 2006, la Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick (la Commission) autorisa la publication en vue de recueillir des commentaires du projet de règle NC 41-101 ainsi que les modifications corrélatives découlant de l’abrogation de la version courante de la NC 41-101.

Summary of proposed Rule The purpose of the proposed NI 41-101 rule is to create a comprehensive, seamless and transparent set of national prospectus requirements for all issuers including investment funds. The purpose of adopting the consequential amendments is to conform other related national instruments and policies to the proposed Rule. The proposed NI 41-101 Rule is based on three general principles: a) harmonization and consolidation of prospectus requirements across Canada; b) harmonization with other regulatory instruments; and c) reflect current policy. The proposed NI 41-101 rule and the consequential amendments are another step towards harmonizing the prospectus and continuous disclosure requirements across Canada.

Résumé du projet de norme L’objet du projet de règle NC 41-101 est de créer un régime de prospectus exhaustif, homogène et transparent, d’application pancanadienne pour tous les émetteurs, y compris les fonds d’investissement. L’objet des modifications corrélatives est de conformer au projet de règle les règles et les instructions complémentaires canadiennes connexes. Le projet de règle repose sur trois principes généraux :

Request for Comment The Commission seeks comments on the proposed NI 41-101 rule and the related consequential amendments arising from the repeal of the current version of NI 41-101 as they apply to New Brunswick only.

Demande de commentaires La Commission désire prendre connaissance de vos commentaires au sujet du projet de règle NC 41-101 et les modifications corrélatives découlant de l’abrogation de la version courante de la NC 41-101, mais uniquement dans la mesure où cela s’applique au Nouveau-Brunswick.

How to Obtain a Copy and Provide your Comments The text of the relevant materials can be obtained from the Commission’s website at: www.nbsc-cvmnb.ca. Additionally, a paper copy of the relevant materials may be obtained by writing, telephoning or e-mailing the Commission.

Pour nous faire part de vos commentaires On trouvera les textes règlementaires énoncés ci-dessus par l’entremise du site web de la Commission : www.nbsccvmnb.ca. De plus, on peut se procurer un exemplaire sur papier de l’un ou l’autre de ces documents en communiquant par courrier, par téléphone ou par courriel avec la Commission.

Comments are to be provided, in writing, by no later than February 19, 2007 to:

Veuillez nous faire part de vos commentaires par écrit au plus tard le 19 février 2007 à l’adresse suivante :

Secretary New Brunswick Securities Commission 85 Charlotte Street, Suite 300 Saint John, N.B. E2L 2J2 Telephone: 506-658-3060 Toll Free: 1-866-933-2222 (within NB only)

Secrétaire Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick 85, rue Charlotte, bureau 300 Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2B5 Téléphone : 506-658-3060 Sans frais : 1-866-933-2222 (au Nouveau-Brunswick seulement) Télécopieur : 506-658-3059 Courriel : [email protected]

Fax: 506-658-3059 E-mail: [email protected]

a)

refonte et harmonisation dans l’ensemble du Canada;

b) harmonisation avec d’autres règles; et c) prise en compte des principes actuels. Le projet de règle NC 41-101 et les modifications corrélatives représentent une avancée supplémentaire vers l’harmonisation des obligations relatives au prospectus et des obligations d’information dans l’ensemble du Canada.

The Royal Gazette — January 17, 2007

If you are not sending your comments by e-mail, please send a diskette containing your comments (PDF or Word). We cannot keep submissions confidential because securities legislation in certain provinces requires that a summary of the written comments received during the comment period be published.

116

Gazette royale — 17 janvier 2007

Si vous n’envoyez pas vos commentaires par courrier électronique, vous devrez nous en faire parvenir une copie sur disquette (Word ou PDF). Nous sommes incapables de garantir la confidentialité des commentaires formulés, étant donné que les mesures législatives sur les valeurs mobilières de certaines provinces exigent que soit publié un résumé des observations écrites qui sont reçues au cours de la période de consultation.

Questions If you have any questions, please refer them to:

Questions Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec la personne suivante :

Kevin Hoyt Director and Chief Financial Officer New Brunswick Securities Commission Telephone: 506-643-7691 E-mail: [email protected]

Kevin Hoyt Directeur des services financiers généraux et chef des finances Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick Téléphone : 506-643-7691 Courriel : [email protected]

________________

________________

NOTICE OF RULE NEW BRUNSWICK IMPLEMENTING INSTRUMENT 55-804 (II 55-804) ADOPTING NATIONAL INSTRUMENT 55-102 – SYSTEM FOR ELECTRONIC DISCLOSURE BY INSIDERS (SEDI) (NI 55-102), FORMS 55-102F1, 55-102F2, 55-102F3, 55-102F4, 55-102F5, 55-102F6 (Forms), AND COMPANION POLICY 55-102CP (55-102CP).

AVIS DE RÈGLE NORME DE MISE EN APPLICATION NÉO-BRUNSWICKOISE 55-804 (NMA 55-804) METTANT EN OEUVRE LA NORME CANADIENNE 55-102 – SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE DÉCLARATION DES INITIÉS (SEDI) (NC 55-102), ANNEXES 55-102A1, 55-102A2, 55-102A3, 55-102A4, 55-102A5, 55-102A6, ET L’INSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE 55-102IC (55-102IC).

Ministerial Consent On December 5, 2006, the Minister of Justice consented to the making of II 55-804 adopting NI 55-102, its Forms and 55-102CP.

Consentement ministériel Le 5 décembre 2006, le ministre de la Justice a donné son consentement à l’adoption de la NMA 55-804 mettant en oeuvre la NC 55-102, les annexes et l’Instruction complémentaire 55-102IC.

Summary of Rules NI 55-102 sets out the requirements and procedures relating to the electronic filing of various insider reports, such as Insider Profile, Insider Report, Issuer Profile Supplement, Event Report and User Registration Form. All reporting issuers, with the exception of mutual funds, are subject to the Instrument. They are required to file insider reports within the prescribed timeline and to keep their profile current. There are no filing fees associated with SEDI filings.

Résumé de la règle La NC 55-102 énonce les règles et politiques régissant le dépôt électronique de diverses déclarations d’initiés, notamment le profil d’initié, la déclaration d’initié, le supplément de profil d’émetteur, la déclaration d’opération sur titres et le formulaire d’inscription de l’utilisateur. Le SEDI est destiné aux émetteurs assujettis autres que les fonds communs de placement, et il ne sert pas à percevoir les droits de dépôt.

Effective Date II 55-804 adopting NI 55-102 comes into force on December 29, 2006.

Date d’entrée en vigueur La NMA 55-804 mettant en oeuvre la NC 55-102 est entrée en vigueur le 29 décembre 2006.

How to Obtain a Copy The texts of II 55-804, NI 55-102, its Forms and 55-102CP can be obtained from the Commission’s website: www.nbsccvmnb.ca

Pour obtenir des exemplaires des documents On trouvera les textes de la NMA 55-804, la NC 55-102, les Annexes ainsi que 55-102IC par l’entremise du site Web de la Commission : www.nbsc-cvmnb.ca

A paper copy may be obtained from the Commission by writing, telephoning or e-mailing:

On peut se procurer un exemplaire sur papier de l’un ou l’autre de ces documents en communiquant par courrier, par téléphone ou par courriel avec la Commission :

The Royal Gazette — January 17, 2007

Secretary New Brunswick Securities Commission 85 Charlotte Street, Suite 300 Saint John, N.B. E2L 2J2 Telephone: 506-658-3060 Toll Free: 1-866-933-2222 (within NB only) Fax: 506-658-3059 E-mail: [email protected]

117

Gazette royale — 17 janvier 2007

Secrétaire Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick 85, rue Charlotte, bureau 300 Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2 Téléphone : 506-658-3060 Sans frais : 1-866-933-2222 (au Nouveau-Brunswick seulement) Télécopieur : 506-658-3059 Courriel : [email protected]

________________

________________

NOTICE OF RULE NEW BRUNSWICK IMPLEMENTING INSTRUMENT 55-803 (II 55-803) ADOPTING MULTILATERAL INSTRUMENT 55-103 – INSIDER REPORTING FOR CERTAIN DERIVATIVE TRANSACTIONS (EQUITY MONETIZATION) (MI 55-103), AND IMPLEMENTING COMPANION POLICY 55-103CP (55-103CP)

AVIS DE RÈGLE NORME DE MISE EN APPLICATION NÉO-BRUNSWICKOISE 55-803 (NMA 55-803) METTANT EN OEUVRE LA NORME MULTILATÉRALE 55-103 – DÉCLARATIONS D’INITIÉS POUR CERTAINES OPÉRATIONS SUR DÉRIVÉS (MONÉTISATION D’ACTIONS) (NM 55-103) ET L’INSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE 55-103IC (55-103IC).

Ministerial Consent On December 20, 2006, the Minister of Justice consented to the making of II 55-803 adopting MI 55-103 and implementing 55-103CP.

Consentement ministériel Le 20 décembre 2006, le ministre de la Justice a donné son consentement à l’adoption de la NMA 55-803 mettant en oeuvre la NM 55-103 et 55-103IC.

Summary of Rule MI 55-103 reflects a principles-based approach to monetization transactions. If an insider enters into a transaction which satisfies one or more of the policy rationales for insider reporting, but for technical reasons, it may legitimately be argued that the insider falls outside of the existing insider reporting requirements, the insider will be required to file an insider report under MI 55-103. In this way, the market can make its own determination as to the significance, if any, of such arrangements.

Résumé de la règle La NM 55-103 procède, en matière d’opérations de monétisation, d’une optique de principes. L’initié qui conclut une opération répondant à un ou plusieurs des fondements des déclarations d’initiés mais qui pourrait prétendre, pour des raisons d’ordre technique, être exclus du champ d’application des règles en vigueur sera tenu, en vertu de la règle de déposer une déclaration d’initié. Ainsi, le marché pourra juger par soi-même de l’importance éventuelle de l’opération visée.

Effective Date II 55-803 adopting MI 55-103 comes into force on January 2, 2007.

Date d’entrée en vigueur La NMA 55-803 mettant en oeuvre la NM 55-103 et 55-103IC est entrée en vigueur le 2 janvier 2007.

How to Obtain a Copy The texts of II 55-803, MI 55-103 and 55-103CP can be obtained from the Commission’s website: www.nbsc-cvmnb.ca

Pour obtenir des exemplaires des documents On trouvera les textes de la NMA 55-803, la NM 55-103 et 55-103IC par l’entremise du site Web de la Commission : www.nbsc-cvmnb.ca

A paper copy may be obtained from the Commission by writing, telephoning or e-mailing:

On peut se procurer un exemplaire sur papier de l’un ou l’autre de ces documents en communiquant par courrier, par téléphone ou par courriel avec la Commission :

Secretary New Brunswick Securities Commission 85 Charlotte Street, Suite 300 Saint John, N.B. E2L 2J2 Telephone: 506-658-3060 Toll Free: 1-866-933-2222 (within NB only)

Secrétaire Commission des valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick 85, rue Charlotte, bureau 300 Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 2J2 Téléphone : 506-658-3060 Sans frais : 1-866-933-2222 (au Nouveau-Brunswick seulement) Télécopieur : 506-658-3059 Courriel : [email protected]

Fax: 506-658-3059 E-mail: [email protected]

The Royal Gazette — January 17, 2007

118

Gazette royale — 17 janvier 2007

Notices of Sale

Avis de vente

TO: STEPHANE DOUGLAS ALBERT, of Village Blanchard, in the County of Gloucester, and MARIE RAYMONDE BRIDEAU, of Brantville, in the County of Northumberland, both from the Province of New Brunswick, Mortgagor; and ALL OTHERS WHOM IT MAY CONCERN. Freehold property situate at Village Blanchard, in the County of Gloucester and Province of New Brunswick. Notice of sale given by La Caisse Populaire de Caraquet Limitée, Mortgagee. Sale in the lobby of the main entrance of the Caraquet Town Hall, located at 10 Du Colisée Street, Caraquet, in the County of Gloucester and Province of New Brunswick, on Tuesday, February 6, 2007, at 9:00 a.m., local time. See advertisement in L’Acadie Nouvelle.

DESTINATAIRES : STEPHANE DOUGLAS ALBERT, de Village Blanchard, comté de Gloucester, et MARIE RAYMONDE BRIDEAU, de Brantville, comté de Northumberland et tous deux de la province du Nouveau-Brunswick, débiteur hypothécaire; et À TOUTES PERSONNES INTÉRESSÉES. Biens en tenure libre situés à Village Blanchard, dans le comté de Gloucester et la province du Nouveau-Brunswick. Avis de vente est donné par La Caisse Populaire de Caraquet Limitée, créancière hypothécaire. La vente aura lieu au vestibule de l’entrée principale de l’Hôtel de ville de Caraquet, situé au 10, rue du Collisée, Caraquet, comté de Gloucester, province du Nouveau-Brunswick, le mardi, 6 février 2007, à 9 h de l’avant-midi, heure locale. Voir l’annonce publiée dans le journal L’Acadie Nouvelle.

MARCO ROBICHAUD C.P. INC., 8 Du Voilier Street, P.O. Box 5658, Caraquet, N.B. E1W 1B7, Telephone: 506-727-3481, Fax: 506-727-2783, Solicitor for the Mortgagee

MARCO ROBICHAUD C.P. INC., 8, rue du Voilier, C.P. 5658, Caraquet (N.-B) E1W 1B7, téléphone : 506727-3481, télécopieur : 506-727-2783, avocat de la créancière hypothécaire

________________

________________

LINDA GODIN / MARIE LINDA GODIN, of 375 Bois Francs Street, in Saint-Léolin, in the County of Gloucester and Province of New Brunswick, Mortgagor and owner of the equity of redemption; CITIFINANCIAL CANADA EAST CORPORATION, holder of the first Mortgage; and to ALL OTHER WHOM IT MAY CONCERN. Freehold premises situate, lying and being at 375 Bois Francs Street, in Saint-Léolin, in the County of Gloucester and Province of New Brunswick. Notice of Sale is given by the holder of the said first Mortgage.

LINDA GODIN/MARIE LINDA GODIN, du 375, rue Bois Francs, Saint-Léolin, comté de Gloucester, province du Nouveau-Brunswick, débitrice hypothécaire et propriétaire du droit de rachat; CITIFINANCIÈRE, CORPORATION DU CANADA EST, titulaire de la première hypothèque; et TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL. Lieux en tenure libre situés au 375, rue Bois Francs, SaintLéolin, comté de Gloucester, province du Nouveau-Brunswick.

Sale to be held on Wednesday, January 31, 2007, at 11:00 o’clock in the morning, at the Court House located at 254 St. Patrick Street, in Bathurst, in the County of Gloucester and Province of New Brunswick. See advertisement in the newspaper The Northern Light. Dated at Edmundston, New Brunswick, this 2nd day of January, 2007.

Avis de vente donné par la titulaire de ladite première hypothèque. La vente aura lieu le mercredi 31 janvier 2007, à 11 h, au palais de justice situé au 254, rue St. Patrick, Bathurst, comté de Gloucester, province du Nouveau-Brunswick. Voir l’annonce publiée dans le journal The Northern Light. Fait à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, le 2 janvier 2007.

GARY J. McLAUGHLIN, McLaughlin Law Offices, Solicitors and agents for CitiFinancial Canada East Corporation

GARY J. McLAUGHLIN, Cabinet Juridique McLaughlin, avocats et représentants de CitiFinancière, corporation du Canada est

________________

________________

TERRANCE I. HARRIS / ENGLES TERRY HARRIS, of 676 Williamstown Road, at Williamstown, in the County of Northumberland and Province of New Brunswick, Mortgagor and owner of the equity of redemption; MARTHA HARRIS, of the same place, spouse of the Mortgagor; CITIFINANCIAL CANADA EAST CORPORATION, holder of the first Mortgage; and to ALL OTHER WHOM IT MAY CONCERN.

TERRANCE I. HARRIS/ENGLES TERRY HARRIS, du 676, chemin de Williamstown, Williamstown, comté de Northumberland, province du Nouveau-Brunswick, débiteur hypothécaire et propriétaire du droit de rachat; MARTHA HARRIS, du même endroit, conjointe du débiteur hypothécaire; CITIFINANCIÈRE, CORPORATION DU CANADA EST, titulaire de la première hypothèque; et TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL.

The Royal Gazette — January 17, 2007

Freehold premises situate, lying and being at of 676 Williamstown Road, at Williamstown, in the County of Northumberland and Province of New Brunswick. Notice of Sale is given by the holder of the said first Mortgage. Sale to be held on Thursday, February 1, 2007, at 11:00 o’clock in the morning, at the Court House located at 673 King George Highway, in Miramichi, in the County of Northumberland and Province of New Brunswick. See advertisement in the newspaper Miramichi Leader. Dated at Edmundston, New Brunswick, this 2nd day of January, 2007.

119

Gazette royale — 17 janvier 2007

Lieux en tenure libre situés au 676, chemin de Williamstown, Williamstown, comté de Northumberland, province du Nouveau-Brunswick. Avis de vente donné par la titulaire de ladite première hypothèque. La vente aura lieu le jeudi 1er février 2007, à 11 h, au palais de justice situé au 673, route King George, Miramichi, comté de Northumberland, province du Nouveau-Brunswick. Voir l’annonce publiée dans le journal Miramichi Leader. Fait à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, le 2 janvier 2007.

GARY J. McLAUGHLIN, McLaughlin Law Offices, Solicitors and agents for CitiFinancial Canada East Corporation

GARY J. McLAUGHLIN, Cabinet Juridique McLaughlin, avocats et représentants de CitiFinancière, corporation du Canada est

________________

________________

PAUL YEE / YOWKWE YEE and JOANNE YEE / HAROLDINE JOANNE YEE, of 27 Brydges Street, in Pointe-du-Chêne, in the County of Westmorland and Province of New Brunswick, Mortgagors and owners of the equity of redemption; CITIFINANCIAL CANADA EAST CORPORATION, holder of the first Mortgage; and to ALL OTHER WHOM IT MAY CONCERN. Freehold premises situate, lying and being at 27 Brydges Street, in Pointe-du-Chêne, in the County of Westmorland and Province of New Brunswick. Notice of sale is given by the holder of the said first Mortgage.

PAUL YEE/YOWKWE YEE et JOANNE YEE/ HAROLDINE JOANNE YEE, du 27, rue Brydges, Pointe-du-Chêne, comté de Westmorland, province du Nouveau-Brunswick, débiteurs hypothécaires et propriétaires du droit de rachat; CITIFINANCIÈRE, CORPORATION DU CANADA EST, titulaire de la première hypothèque; et TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL. Lieux en tenure libre situés au 27, rue Brydges, Pointe-du-Chêne, comté de Westmorland, province du Nouveau-Brunswick. Avis de vente donné par la titulaire de ladite première hypothèque. La vente aura lieu le mercredi 31 janvier 2007, à 10 h, à l’hôtel de ville situé au 655, rue Main, Moncton, comté de Westmorland, province du Nouveau-Brunswick. Voir l’annonce publiée dans le journal Times & Transcript.

Sale to be held on Wednesday, January 31, 2007, at 10:00 o’clock in the morning, at the City Hall located at 655 Main Street, in Moncton, in the County of Westmorland and Province of New Brunswick. See advertisement in the newspaper Times & Transcript. Dated at Edmundston, New Brunswick, this 3rd day of January, 2007.

Fait à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, le 3 janvier 2007.

GARY J. McLAUGHLIN, Q.C., McLaughlin Law Offices, Solicitors and agents for CitiFinancial Canada East Corporation

GARY J. McLAUGHLIN, C.R., Cabinet Juridique McLaughlin, avocats et représentants de CitiFinancière, corporation du Canada est

________________

________________

RICHARD MELVIN BREAU and KAREN ANN ANDERSON, of 63 Sunset Boulevard, at McLeod Hill, in the County of York and Province of New Brunswick, Mortgagors and owners of the equity of redemption; CITIFINANCIAL CANADA EAST CORPORATION, holder of the first Mortgage; and to ALL OTHER WHOM IT MAY CONCERN. Freehold premises situate, lying and being at 63 Sunset Boulevard, at McLeod Hill, in the County of York and Province of New Brunswick. Notice of sale is given by the holder of the said first Mortgage.

RICHARD MELVIN BREAU et KAREN ANN ANDERSON, du 63, boulevard Sunset, McLeod Hill, comté de York, province du Nouveau-Brunswick, débiteurs hypothécaires et propriétaires du droit de rachat; CITIFINANCIÈRE, CORPORATION DU CANADA EST, titulaire de la première hypothèque; et TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL. Lieux en tenure libre situés au 63, boulevard Sunset, McLeod Hill, comté de York, province du Nouveau-Brunswick.

Sale to be held on Wednesday, January 31, 2007, at 11:00 o’clock in the morning, at the Court House located at 427 Queen Street, in Fredericton, in the County of York and Province of New Brunswick. See advertisement in the newspaper The Daily Gleaner.

Avis de vente donné par la titulaire de ladite première hypothèque. La vente aura lieu le mercredi 31 janvier 2007, à 11 h, au palais de justice situé au 427, rue Queen, Fredericton, comté de York, province du Nouveau-Brunswick. Voir l’annonce publiée dans le journal The Daily Gleaner.

The Royal Gazette — January 17, 2007

120

Gazette royale — 17 janvier 2007

Dated at Edmundston, New Brunswick, this 3rd day of January, 2007.

Fait à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, le 3 janvier 2007.

GARY J. McLAUGHLIN, Q.C., McLaughlin Law Offices, Solicitors and agents for CitiFinancial Canada East Corporation

GARY J. McLAUGHLIN, C.R., Cabinet Juridique McLaughlin, avocats et représentants de CitiFinancière, corporation du Canada est

________________

________________

ESTATE OF ARNOLD MacMILLAN and RITA HELEN MacMILLAN, of 4266 Route 114, at Lower Cape, in the County of Albert and Province of New Brunswick, Mortgagors and owners of the equity of redemption; CITIFINANCIAL CANADA EAST CORPORATION, holder of the first Mortgage; and to ALL OTHER WHOM IT MAY CONCERN.

LA SUCCESSION D’ARNOLD MacMILLAN et RITA HELEN MacMILLAN, du 4266, route 114, Lower Cape, comté d’Albert, province du Nouveau-Brunswick, débiteurs hypothécaires et propriétaires du droit de rachat; CITIFINANCIÈRE, CORPORATION DU CANADA EST, titulaire de la première hypothèque; et TOUT AUTRE INTÉRESSÉ ÉVENTUEL. Lieux en tenure libre situés au 4266, route 114, Lower Cape, comté d’Albert, province du Nouveau-Brunswick.

Freehold premises situate, lying and being at 4266 Route 114, at Lower Cape, in the County of Albert and Province of New Brunswick. Notice of sale is given by the holder of the said first Mortgage. Sale to be held on Thursday, February 1, 2007, at 11:00 o’clock in the morning, at the Town Hall located at 30 Honour House Street, at Riverview, in the County of Albert and Province of New Brunswick. See advertisement in the newspaper Times & Transcript. Dated at Edmundston, New Brunswick, this 3rd day of January, 2007.

Avis de vente donné par la titulaire de ladite première hypothèque. La vente aura lieu le jeudi 1er février 2007, à 11 h, à l’hôtel de ville situé au 30, rue Honour House, Riverview, comté d’Albert, province du Nouveau-Brunswick. Voir l’annonce publiée dans le journal Times & Transcript. Fait à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, le 3 janvier 2007.

GARY J. McLAUGHLIN, Q.C., McLaughlin Law Offices, Solicitors and agents for CitiFinancial Canada East Corporation

GARY J. McLAUGHLIN, C.R., Cabinet Juridique McLaughlin, avocats et représentants de CitiFinancière, corporation du Canada est

Notice to Advertisers

Avis aux annonceurs

The Royal Gazette is published every Wednesday under the authority of the Queen’s Printer Act. Documents must be received by the Royal Gazette Coordinator, in the Queen’s Printer Office, no later than noon, at least seven days prior to Wednesday’s publication. Each document must be separate from the covering letter. Signatures on documents must be immediately followed by the printed name. The Queen’s Printer may refuse to publish a document if any part of it is illegible, and may delay publication of any document for administrative reasons. Prepayment is required for the publication of all documents. Standard documents have the following set fees:

La Gazette royale est publiée tous les mercredis conformément à la Loi sur l’Imprimeur de la Reine. Les documents à publier doivent parvenir à la coordonnatrice de la Gazette royale, au bureau de l’Imprimeur de la Reine, à midi, au moins sept jours avant le mercredi de publication. Chaque avis doit être séparé de la lettre d’envoi. Les noms des signataires doivent suivre immédiatement la signature. L’Imprimeur de la Reine peut refuser de publier un avis dont une partie est illisible et retarder la publication d’un avis pour des raisons administratives. Le paiement d’avance est exigé pour la publication des avis. Voici les tarifs pour les avis courants :

Notices Notice of the intention to apply for the enactment of a private bill Originating process Order of a court Notice under the Absconding Debtors Act Notice under the General Rules under the Law Society Act, 1996, of disbarment or suspension or of application for reinstatement or readmission

Cost per Insertion $ 20 $ $ $ $

25 25 20 20

Avis Avis d’intention de demander l’adoption d’un projet de loi d’intérêt privé Acte introductif d’instance Ordonnance rendue par une cour Avis exigé par la Loi sur les débiteurs en fuite Avis de radiation ou de suspension ou de demande de réintégration ou de réadmission, exigé par les Règles générales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur le Barreau

Coût par parution 20 $ 25 $ 25 $ 20 $ 20 $

The Royal Gazette — January 17, 2007

121

Notice of examination under the Licensed Practical Nurses Act Notice under the Motor Carrier Act Any document under the Political Process Financing Act

$ 25

Notice to creditors under New Brunswick Regulation 84-9 under the Probate Court Act

$ 20

Notice under the Quieting of Titles Act (Form 70B)

$120

$ 30 $ 20

Note: Survey Maps cannot exceed 8.5″ x 14″

Avis d’examen exigé par la Loi sur les infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés Avis exigé par la Loi sur les transports routiers Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur le financement de l’activité politique Avis aux créanciers exigé par le Règlement du NouveauBrunswick 84-9 établi en vertu de la Loi sur la Cour des successions Avis exigé par la Loi sur la validation des titres de propriété

25 $ 30 $ 20 $ 20 $ 120 $

(Formule 70B) Nota : Les plans d’arpentage ne doivent pas dépasser 8,5 po sur 14 po

Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is 1/2 page in length or less

$ 20

Notice under the Sale of Lands Publication Act, if the notice is greater than 1/2 page in length

$ 75

Any document under the Winding-up and Restructuring Act (Canada) Notice of a correction

$ 20

Any other document

Gazette royale — 17 janvier 2007

charge is the same as for publishing the original document $3.50 for each cm or less

Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces, si l’avis est d’une demi-page ou moins en longueur Avis exigé par la Loi sur la vente de biens-fonds par voie d’annonces, si l’avis est de plus d’une demi-page en longueur Tout document devant être publié en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations (Canada) Avis d’une correction

Tout autre document

20 $ 75 $ 20 $ les frais sont les mêmes que ceux imposés pour la publication du document original 3,50 $ pour chaque cm ou moins

Payments can be made by cash, MasterCard, VISA, cheque or money order (payable to the Minister of Finance). No refunds will be issued for cancellations.

Les paiements peuvent être faits en espèces, par carte de crédit MasterCard ou VISA, ou par chèque ou mandat (établi à l’ordre du ministre des Finances). Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation.

The official version of The Royal Gazette is available free on-line each Wednesday. This free on-line service replaces the printed annual subscription service. The Royal Gazette can be accessed on-line at:

La version officielle de la Gazette royale est disponible gratuitement et en ligne chaque mercredi. Ce service gratuit en ligne remplace le service d’abonnement annuel. Vous trouverez la Gazette royale à l’adresse suivante :

http://www.gnb.ca/0062/gazette/index-e.asp

http://www.gnb.ca/0062/gazette/index-f.asp

Print-on-demand copies of The Royal Gazette are available, at the Office of the Queen’s Printer, at $4.00 per copy plus 14% tax, plus shipping and handling where applicable.

Nous offrons, sur demande, des exemplaires de la Gazette royale, au bureau de l’Imprimeur de la Reine, pour la somme de 4 $ l’exemplaire, plus la taxe de 14 %, ainsi que les frais applicables de port et de manutention.

Office of the Queen’s Printer 670 King Street, Room 117 P.O. Box 6000 Fredericton, NB E3B 5H1 Tel: (506) 453-2520 Fax: (506) 457-7899 E-mail: [email protected]

Bureau de l’Imprimeur de la Reine 670, rue King, pièce 117 C.P. 6000 Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1 Tél. : (506) 453-2520 Téléc. : (506) 457-7899 Courriel : [email protected]

QUEEN’S PRINTER FOR NEW BRUNSWICK

© IMPRIMEUR DE LA REINE POUR LE NOUVEAU-BRUNSWICK

All rights reserved / Tous droits réservés